VERTICALES INTERCOM SL

Activa

AV ALCALDE BARNILS NUM.64-68 MODULO D P.1 (SANT CUGAT DEL VALLES).
 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 26/02/2019

TABARES MONTOYA BEATRIZ

Apoderado solidario
Nombramiento: 26/02/2019

GARCIA CARBAJOSA ELISA

Apoderado solidario
Nombramiento: 26/02/2019

ZAVALA AZOR FERNANDO JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 16/11/2018

VIVES MAS ESTUDIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 20/08/2018

ONESEVEN AUDITORIA CONSULTORIA SL

Auditor de cuentas
Cese: 22/05/2018

BALDRICH MARTIN FRANCESC XAVIER

Consejero
Cese: 22/05/2018

LLORENTE MORAL FRANCISCO JAVIER

Consejero
Cese: 20/02/2018

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Consejero
Cese: 20/02/2018

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Presidente
Cese: 20/02/2018

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Consejero delegado
Nombramiento: 20/02/2018

BONSAI VENTURE CAPITAL SCR SA

Consejero
Nombramiento: 20/02/2018

CEBRIAN MONEREO FRANCISCO JAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 20/02/2018

SILPRICOT SL

Consejero
Nombramiento: 20/02/2018

SILPRICOT SL

Presidente
Nombramiento: 20/02/2018

SILPRICOT SL

Consejero delegado
Nombramiento: 20/02/2018

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 09/03/2017

ZAVALA AZOR FERNANDO JOSE

Apoderado solidario
Cese: 12/01/2016

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Administrador único
Nombramiento: 12/01/2016

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Consejero
Nombramiento: 12/01/2016

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Presidente
Nombramiento: 12/01/2016

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Consejero delegado
Nombramiento: 12/01/2016

ZAVALA AZOR FERNANDO

Consejero
Nombramiento: 12/01/2016

BALDRICH MARTIN FRANCESC XAVIER

Consejero
Nombramiento: 12/01/2016

LLORENTE MORAL FRANCISCO JAVIER

Consejero
Nombramiento: 12/01/2016

GRUPO INTERCOM DE CAPITAL SCR PYME SA

Consejero
Nombramiento: 12/01/2016

GONZALEZ BARROS BELLSOLA ANTONIO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 12/01/2016

GARCIA BO JORDI

Secretario no consejero
Nombramiento: 05/09/2014

VIVES MAS ESTUDIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL

Auditor de cuentas
Cese: 16/04/2014

SANCHEZ MARTIN ANTONIO IGNACIO

Apoderado
Cese: 16/04/2014

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Apoderado
Nombramiento: 16/04/2014

MEDINA ROBLES DIVINA

Apoderado solidario
Nombramiento: 16/04/2014

GARCIA BO JORDI

Apoderado solidario
Nombramiento: 16/04/2014

MATIAS HERRERO MAGALI

Apoderado solidario
Cese: 19/03/2014

INTERCOM FACTORY SL

Administrador único
Cese: 19/03/2014

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 19/03/2014

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Administrador único

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by VERTICALES INTERCOM SL

02/08/2021 Details of the advert (364657) Registry data: T 45827 , F 28, S 8, H B 360009, I/A 22 (23.07.21).

    30/07/2019 Details of the advert (330724) Registry data: T 45827 , F 27, S 8, H B 360009, I/A 21 (23.07.19).

    • Ampliación de Capital

      Capital: 96.525,00 Euros. Resultante Suscrito: 148.500,00 Euros.

    30/07/2019 Details of the advert (330722) Registry data: T 45827 , F 25, S 8, H B 360009, I/A 20 (23.07.19).

    • Reducción de Capital

      Importe reducción: 96.525,00 Euros. Resultante Suscrito: 51.975,00 Euros.

    • Escisión Parcial

      Sociedades beneficiarias de la escisión: THE MIND HUB COMPANY S.L.

    16/04/2019 Details of the advert (427)

    • Depósitos de proyectos de escisión parcial

    26/02/2019 Details of the advert (89062) Registry data: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 19 (14.02.19).

    • Nombramientos

      APODERAD.SOL: TABARES MONTOYA BEATRIZ;GARCIA CARBAJOSA ELISA;ZAVALA AZOR FERNANDO JOSE.

    16/11/2018 Details of the advert (456379) Registry data: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 18 ( 7.11.18).

    • Nombramientos

      AUDIT.CUENT.: VIVES MAS ESTUDIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL.

    06/11/2018 Details of the advert (442079) Registry data: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 17 (25.10.18).

    • Cambio de domicilio social

      AV ALCALDE BARNILS NUM.64-68 MODULO D P.1 (SANT CUGAT DEL VALLES).

    20/08/2018 Details of the advert (342506) Registry data: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 16 (10.08.18).

    • Nombramientos

      AUDIT.CUENT.: ONESEVEN AUDITORIA CONSULTORIA SL.

    22/05/2018 Details of the advert (214382) Registry data: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 15 (10.05.18).

    • Revocaciones

      CONSEJERO: BALDRICH MARTIN FRANCESC XAVIER;LLORENTE MORAL FRANCISCO JAVIER.

    20/02/2018 Details of the advert (81673) Registry data: T 45827 , F 21, S 8, H B 360009, I/A 14 (12.02.18).

    • Revocaciones

      CONSEJERO: FERRER PUJOL JOSE LUIS. PRESIDENTE: FERRER PUJOL JOSE LUIS. CONS. DELEG.: FERRER PUJOL JOSE LUIS.

    • Nombramientos

      CONSEJERO: BONSAI VENTURE CAPITAL SCR SA. REPR.143 RRM: CEBRIAN MONEREO FRANCISCO JAVIER. CONSEJERO: SILPRICOT SL. PRESIDENTE: SILPRICOT SL. CONS. DELEG.: SILPRICOT SL. REPR.143 RRM: FERRER PUJOL JOSE LUIS.

    • Modificaciones Estatutarias

      MODIFICACION DEL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL.

    Mercantile Registry documents related: 24

    #CVE
    Date
    State
    BORME-A-2021-146-08 02/08/2021 Barcelona Descargar
    BORME-A-2019-144-08 30/07/2019 Barcelona Descargar
    BORME-A-2019-144-08 30/07/2019 Barcelona Descargar
    BORME-B-2019-74-08 16/04/2019 Barcelona Descargar
    BORME-A-2019-39-08 26/02/2019 Barcelona Descargar
    BORME-A-2018-220-08 16/11/2018 Barcelona Descargar
    BORME-A-2018-213-08 06/11/2018 Barcelona Descargar
    BORME-A-2018-159-08 20/08/2018 Barcelona Descargar
    BORME-A-2018-96-08 22/05/2018 Barcelona Descargar
    BORME-A-2018-36-08 20/02/2018 Barcelona Descargar