VERTICALES INTERCOM SL

Activa

AV ALCALDE BARNILS NUM.64-68 MODULO D P.1 (SANT CUGAT DEL VALLES).
 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Lokinn.com no comercialitza ni ven les dades de les empreses, només ofereix la seua informació públicament.

Si vol actualitzar-la o modificar-la registra't gratuïtament

Últims moviments

Data
Nom
Nombramiento: 26/02/2019

TABARES MONTOYA BEATRIZ

Apoderado solidario
Nombramiento: 26/02/2019

GARCIA CARBAJOSA ELISA

Apoderado solidario
Nombramiento: 26/02/2019

ZAVALA AZOR FERNANDO JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 16/11/2018

VIVES MAS ESTUDIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 20/08/2018

ONESEVEN AUDITORIA CONSULTORIA SL

Auditor de cuentas
Cese: 22/05/2018

BALDRICH MARTIN FRANCESC XAVIER

Consejero
Cese: 22/05/2018

LLORENTE MORAL FRANCISCO JAVIER

Consejero
Cese: 20/02/2018

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Consejero
Cese: 20/02/2018

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Presidente
Cese: 20/02/2018

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Consejero delegado
Nombramiento: 20/02/2018

BONSAI VENTURE CAPITAL SCR SA

Consejero
Nombramiento: 20/02/2018

CEBRIAN MONEREO FRANCISCO JAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 20/02/2018

SILPRICOT SL

Consejero
Nombramiento: 20/02/2018

SILPRICOT SL

Presidente
Nombramiento: 20/02/2018

SILPRICOT SL

Consejero delegado
Nombramiento: 20/02/2018

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 09/03/2017

ZAVALA AZOR FERNANDO JOSE

Apoderado solidario
Cese: 12/01/2016

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Administrador único
Nombramiento: 12/01/2016

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Consejero
Nombramiento: 12/01/2016

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Presidente
Nombramiento: 12/01/2016

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Consejero delegado
Nombramiento: 12/01/2016

ZAVALA AZOR FERNANDO

Consejero
Nombramiento: 12/01/2016

BALDRICH MARTIN FRANCESC XAVIER

Consejero
Nombramiento: 12/01/2016

LLORENTE MORAL FRANCISCO JAVIER

Consejero
Nombramiento: 12/01/2016

GRUPO INTERCOM DE CAPITAL SCR PYME SA

Consejero
Nombramiento: 12/01/2016

GONZALEZ BARROS BELLSOLA ANTONIO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 12/01/2016

GARCIA BO JORDI

Secretario no consejero
Nombramiento: 05/09/2014

VIVES MAS ESTUDIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL

Auditor de cuentas
Cese: 16/04/2014

SANCHEZ MARTIN ANTONIO IGNACIO

Apoderado
Cese: 16/04/2014

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Apoderado
Nombramiento: 16/04/2014

MEDINA ROBLES DIVINA

Apoderado solidario
Nombramiento: 16/04/2014

GARCIA BO JORDI

Apoderado solidario
Nombramiento: 16/04/2014

MATIAS HERRERO MAGALI

Apoderado solidario
Cese: 19/03/2014

INTERCOM FACTORY SL

Administrador único
Cese: 19/03/2014

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 19/03/2014

FERRER PUJOL JOSE LUIS

Administrador único

Registres Mercantils relacionats

Actes mercantils publicats en l'edició digital del Registre Mercantil relacionats o inscrits per VERTICALES INTERCOM SL

02/08/2021 Detalls de l'anunci (364657) Dades registrals: T 45827 , F 28, S 8, H B 360009, I/A 22 (23.07.21).

    30/07/2019 Detalls de l'anunci (330724) Dades registrals: T 45827 , F 27, S 8, H B 360009, I/A 21 (23.07.19).

    • Ampliación de Capital

      Capital: 96.525,00 Euros. Resultante Suscrito: 148.500,00 Euros.

    30/07/2019 Detalls de l'anunci (330722) Dades registrals: T 45827 , F 25, S 8, H B 360009, I/A 20 (23.07.19).

    • Reducción de Capital

      Importe reducción: 96.525,00 Euros. Resultante Suscrito: 51.975,00 Euros.

    • Escisión Parcial

      Sociedades beneficiarias de la escisión: THE MIND HUB COMPANY S.L.

    16/04/2019 Detalls de l'anunci (427)

    • Depósitos de proyectos de escisión parcial

    26/02/2019 Detalls de l'anunci (89062) Dades registrals: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 19 (14.02.19).

    • Nombramientos

      APODERAD.SOL: TABARES MONTOYA BEATRIZ;GARCIA CARBAJOSA ELISA;ZAVALA AZOR FERNANDO JOSE.

    16/11/2018 Detalls de l'anunci (456379) Dades registrals: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 18 ( 7.11.18).

    • Nombramientos

      AUDIT.CUENT.: VIVES MAS ESTUDIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL.

    06/11/2018 Detalls de l'anunci (442079) Dades registrals: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 17 (25.10.18).

    • Cambio de domicilio social

      AV ALCALDE BARNILS NUM.64-68 MODULO D P.1 (SANT CUGAT DEL VALLES).

    20/08/2018 Detalls de l'anunci (342506) Dades registrals: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 16 (10.08.18).

    • Nombramientos

      AUDIT.CUENT.: ONESEVEN AUDITORIA CONSULTORIA SL.

    22/05/2018 Detalls de l'anunci (214382) Dades registrals: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 15 (10.05.18).

    • Revocaciones

      CONSEJERO: BALDRICH MARTIN FRANCESC XAVIER;LLORENTE MORAL FRANCISCO JAVIER.

    20/02/2018 Detalls de l'anunci (81673) Dades registrals: T 45827 , F 21, S 8, H B 360009, I/A 14 (12.02.18).

    • Revocaciones

      CONSEJERO: FERRER PUJOL JOSE LUIS. PRESIDENTE: FERRER PUJOL JOSE LUIS. CONS. DELEG.: FERRER PUJOL JOSE LUIS.

    • Nombramientos

      CONSEJERO: BONSAI VENTURE CAPITAL SCR SA. REPR.143 RRM: CEBRIAN MONEREO FRANCISCO JAVIER. CONSEJERO: SILPRICOT SL. PRESIDENTE: SILPRICOT SL. CONS. DELEG.: SILPRICOT SL. REPR.143 RRM: FERRER PUJOL JOSE LUIS.

    • Modificaciones Estatutarias

      MODIFICACION DEL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL.

    Documents del Registre Mercantil relacionats: 24

    #CVE
    Data
    Provincia
    BORME-A-2021-146-08 02/08/2021 Barcelona Descargar
    BORME-A-2019-144-08 30/07/2019 Barcelona Descargar
    BORME-A-2019-144-08 30/07/2019 Barcelona Descargar
    BORME-B-2019-74-08 16/04/2019 Barcelona Descargar
    BORME-A-2019-39-08 26/02/2019 Barcelona Descargar
    BORME-A-2018-220-08 16/11/2018 Barcelona Descargar
    BORME-A-2018-213-08 06/11/2018 Barcelona Descargar
    BORME-A-2018-159-08 20/08/2018 Barcelona Descargar
    BORME-A-2018-96-08 22/05/2018 Barcelona Descargar
    BORME-A-2018-36-08 20/02/2018 Barcelona Descargar