STUDIUMSER SL

Extinta

AVDA AMERICA 32 - 2& PLANTA, DESPACHO 253, FRAPEMA (ALCORCON).
 Alcorcón, Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 26/01/2017

CASALS COMAS JAUME

Consejero
Cese: 26/01/2017

CASALS COMAS JAUME

Secretario
Nombramiento: 26/01/2017

BAGO I MONS JORDI-RAFEL

Consejero
Nombramiento: 26/01/2017

BAGO I MONS JORDI-RAFEL

Secretario
Cese: 15/09/2016

BORRAS DALMAU ANTONI

Apoderado
Cese: 15/09/2016

PUIG I LOPEZ JOSEP

Apoderado
Cese: 15/09/2016

BAGO I MONS RAIMON

Apoderado
Nombramiento: 17/05/2016

TORRENT I BUSQUET JAUME

Apoderado
Nombramiento: 17/05/2016

VIVES I ARNIJAS ALBERT

Apoderado
Cese: 04/08/2015

GARCIA GASCONS JOAN

Consejero
Cese: 04/08/2015

GARCIA GASCONS JOAN

Secretario
Cese: 04/08/2015

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Consejero
Cese: 04/08/2015

SITJAS I GUELL JOSEP

Consejero
Cese: 04/08/2015

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Presidente
Cese: 04/08/2015

GARCIA GASCONS JOAN

Apoderado solidario
Cese: 04/08/2015

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Apoderado solidario
Nombramiento: 04/08/2015

BAYER RAICH JOSEP MARIA

Consejero
Nombramiento: 04/08/2015

CASALS COMAS JAUME

Consejero
Nombramiento: 04/08/2015

SERRA GRAS LLUIS

Consejero
Nombramiento: 04/08/2015

BAYER RAICH JOSEP MARIA

Presidente
Nombramiento: 04/08/2015

CASALS COMAS JAUME

Secretario
Nombramiento: 04/08/2015

BAYER RAICH JOSEP MARIA

Apoderado
Nombramiento: 04/08/2015

CASALS COMAS JAUME

Apoderado
Cese: 26/06/2012

MAS CRUAÑAS MIGUEL

Apoderado
Nombramiento: 26/06/2012

BAGO I MONS RAIMON

Apoderado
Cese: 26/06/2012

JANER NICOLAU ANTONI

Consejero
Cese: 26/06/2012

VAZQUEZ CAMPS EUSEBI

Consejero
Cese: 26/06/2012

JANER NICOLAU ANTONI

Presidente
Cese: 26/06/2012

JANER NICOLAU ANTONI

Apoderado
Cese: 26/06/2012

GARCIA GASCONS JOAN

Apoderado
Nombramiento: 26/06/2012

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Consejero
Nombramiento: 26/06/2012

SITJAS I GUELL JOSEP

Consejero
Nombramiento: 26/06/2012

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Presidente
Nombramiento: 26/06/2012

GARCIA GASCONS JOAN

Apoderado solidario
Nombramiento: 26/06/2012

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/03/2011

MONTOLIU PASTOR ANTONIO

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/03/2011

FERRER SANTAMARIA MARGARITA

Apoderado solidario
Nombramiento: 16/10/2009

FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL

Auditor

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by STUDIUMSER SL

30/11/2017 Details of the advert (472012) Registry data: T 24743 , F 193, S 8, H M 445459, I/A 15 (23.11.17).

  • Otros Conceptos

    CANCELACION DE LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN BARCELONA EQUIPTURIS, S.A. SEGUN OFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL DE DICHA PROVINCIA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 233.2 R.R.M.

  • Extinción

26/01/2017 Details of the advert (42611) Registry data: T 24743 , F 192, S 8, H M 445459, I/A 14 (18.01.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: CASALS COMAS JAUME. Secretario: CASALS COMAS JAUME.

  • Nombramientos

    Consejero: BAGO I MONS JORDI-RAFEL. Secretario: BAGO I MONS JORDI-RAFEL.

15/09/2016 Details of the advert (377126) Registry data: T 24743 , F 192, S 8, H M 445459, I/A 13 ( 7.09.16).

  • Revocaciones

    Apoderado: BORRAS DALMAU ANTONI;PUIG I LOPEZ JOSEP;BAGO I MONS RAIMON.

17/05/2016 Details of the advert (208729) Registry data: T 24743 , F 191, S 8, H M 445459, I/A 12 ( 5.05.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: TORRENT I BUSQUET JAUME;VIVES I ARNIJAS ALBERT.

04/08/2015 Details of the advert (323722) Registry data: T 24743 , F 191, S 8, H M 445459, I/A 11 (25.07.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: GARCIA GASCONS JOAN. Secretario: GARCIA GASCONS JOAN. Consejero: VILELLA I LLIRINOS JOSEP;SITJAS I GUELL JOSEP. Presidente: VILELLA I LLIRINOS JOSEP.

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: GARCIA GASCONS JOAN;VILELLA I LLIRINOS JOSEP.

  • Nombramientos

    Consejero: BAYER RAICH JOSEP MARIA;CASALS COMAS JAUME;SERRA GRAS LLUIS. Presidente: BAYER RAICH JOSEP MARIA. Secretario: CASALS COMAS JAUME. Apoderado: BAYER RAICH JOSEP MARIA;CASALS COMAS JAUME.

15/01/2014 Details of the advert (15347) Registry data: T 24743 , F 191, S 8, H M 445459, I/A 10 ( 7.01.14).

  • Modificaciones Estatutarias

    Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8.

26/06/2012 Details of the advert (269273) Registry data: T 24743 , F 190, S 8, H M 445459, I/A 9 (15.06.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: MAS CRUAÑAS MIGUEL.

  • Nombramientos

    Apoderado: BAGO I MONS RAIMON.

26/06/2012 Details of the advert (269272) Registry data: T 24743 , F 190, S 8, H M 445459, I/A 8 (15.06.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: JANER NICOLAU ANTONI;VAZQUEZ CAMPS EUSEBI. Presidente: JANER NICOLAU ANTONI.

  • Revocaciones

    Apoderado: JANER NICOLAU ANTONI;GARCIA GASCONS JOAN.

  • Nombramientos

    Consejero: VILELLA I LLIRINOS JOSEP;SITJAS I GUELL JOSEP. Presidente: VILELLA I LLIRINOS JOSEP. Apo.Sol.: GARCIA GASCONS JOAN;VILELLA I LLIRINOS JOSEP.

12/03/2012 Details of the advert (117869) Registry data: T 24743 , F 189, S 8, H M 445459, I/A 7 ( 1.03.12).

  • Cambio de domicilio social

    AVDA AMERICA 32 - 2& PLANTA, DESPACHO 253, FRAPEMA (ALCORCON).

24/03/2011 Details of the advert (132921) Registry data: T 24743 , F 188, S 8, H M 445459, I/A 6 (14.03.11).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: MONTOLIU PASTOR ANTONIO;FERRER SANTAMARIA MARGARITA.

Mercantile Registry documents related: 13

#CVE
Date
State
BORME-A-2017-228-28 30/11/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-18-28 26/01/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-177-28 15/09/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-92-28 17/05/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-146-28 04/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-9-28 15/01/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2012-120-28 26/06/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-120-28 26/06/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-50-28 12/03/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-58-28 24/03/2011 Madrid Descargar