STUDIUMSER SL

Extinta

AVDA AMERICA 32 - 2& PLANTA, DESPACHO 253, FRAPEMA (ALCORCON).
 Alcorcón, Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 26/01/2017

CASALS COMAS JAUME

Consejero
Cese: 26/01/2017

CASALS COMAS JAUME

Secretario
Nombramiento: 26/01/2017

BAGO I MONS JORDI-RAFEL

Consejero
Nombramiento: 26/01/2017

BAGO I MONS JORDI-RAFEL

Secretario
Cese: 15/09/2016

BORRAS DALMAU ANTONI

Apoderado
Cese: 15/09/2016

PUIG I LOPEZ JOSEP

Apoderado
Cese: 15/09/2016

BAGO I MONS RAIMON

Apoderado
Nombramiento: 17/05/2016

TORRENT I BUSQUET JAUME

Apoderado
Nombramiento: 17/05/2016

VIVES I ARNIJAS ALBERT

Apoderado
Cese: 04/08/2015

GARCIA GASCONS JOAN

Consejero
Cese: 04/08/2015

GARCIA GASCONS JOAN

Secretario
Cese: 04/08/2015

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Consejero
Cese: 04/08/2015

SITJAS I GUELL JOSEP

Consejero
Cese: 04/08/2015

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Presidente
Cese: 04/08/2015

GARCIA GASCONS JOAN

Apoderado solidario
Cese: 04/08/2015

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Apoderado solidario
Nombramiento: 04/08/2015

BAYER RAICH JOSEP MARIA

Consejero
Nombramiento: 04/08/2015

CASALS COMAS JAUME

Consejero
Nombramiento: 04/08/2015

SERRA GRAS LLUIS

Consejero
Nombramiento: 04/08/2015

BAYER RAICH JOSEP MARIA

Presidente
Nombramiento: 04/08/2015

CASALS COMAS JAUME

Secretario
Nombramiento: 04/08/2015

BAYER RAICH JOSEP MARIA

Apoderado
Nombramiento: 04/08/2015

CASALS COMAS JAUME

Apoderado
Cese: 26/06/2012

MAS CRUAÑAS MIGUEL

Apoderado
Nombramiento: 26/06/2012

BAGO I MONS RAIMON

Apoderado
Cese: 26/06/2012

JANER NICOLAU ANTONI

Consejero
Cese: 26/06/2012

VAZQUEZ CAMPS EUSEBI

Consejero
Cese: 26/06/2012

JANER NICOLAU ANTONI

Presidente
Cese: 26/06/2012

JANER NICOLAU ANTONI

Apoderado
Cese: 26/06/2012

GARCIA GASCONS JOAN

Apoderado
Nombramiento: 26/06/2012

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Consejero
Nombramiento: 26/06/2012

SITJAS I GUELL JOSEP

Consejero
Nombramiento: 26/06/2012

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Presidente
Nombramiento: 26/06/2012

GARCIA GASCONS JOAN

Apoderado solidario
Nombramiento: 26/06/2012

VILELLA I LLIRINOS JOSEP

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/03/2011

MONTOLIU PASTOR ANTONIO

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/03/2011

FERRER SANTAMARIA MARGARITA

Apoderado solidario
Nombramiento: 16/10/2009

FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por STUDIUMSER SL

30/11/2017 Detalles del anuncio (472012) Datos registrales: T 24743 , F 193, S 8, H M 445459, I/A 15 (23.11.17).

  • Otros Conceptos

    CANCELACION DE LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN BARCELONA EQUIPTURIS, S.A. SEGUN OFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL DE DICHA PROVINCIA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 233.2 R.R.M.

  • Extinción

26/01/2017 Detalles del anuncio (42611) Datos registrales: T 24743 , F 192, S 8, H M 445459, I/A 14 (18.01.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: CASALS COMAS JAUME. Secretario: CASALS COMAS JAUME.

  • Nombramientos

    Consejero: BAGO I MONS JORDI-RAFEL. Secretario: BAGO I MONS JORDI-RAFEL.

15/09/2016 Detalles del anuncio (377126) Datos registrales: T 24743 , F 192, S 8, H M 445459, I/A 13 ( 7.09.16).

  • Revocaciones

    Apoderado: BORRAS DALMAU ANTONI;PUIG I LOPEZ JOSEP;BAGO I MONS RAIMON.

17/05/2016 Detalles del anuncio (208729) Datos registrales: T 24743 , F 191, S 8, H M 445459, I/A 12 ( 5.05.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: TORRENT I BUSQUET JAUME;VIVES I ARNIJAS ALBERT.

04/08/2015 Detalles del anuncio (323722) Datos registrales: T 24743 , F 191, S 8, H M 445459, I/A 11 (25.07.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: GARCIA GASCONS JOAN. Secretario: GARCIA GASCONS JOAN. Consejero: VILELLA I LLIRINOS JOSEP;SITJAS I GUELL JOSEP. Presidente: VILELLA I LLIRINOS JOSEP.

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: GARCIA GASCONS JOAN;VILELLA I LLIRINOS JOSEP.

  • Nombramientos

    Consejero: BAYER RAICH JOSEP MARIA;CASALS COMAS JAUME;SERRA GRAS LLUIS. Presidente: BAYER RAICH JOSEP MARIA. Secretario: CASALS COMAS JAUME. Apoderado: BAYER RAICH JOSEP MARIA;CASALS COMAS JAUME.

15/01/2014 Detalles del anuncio (15347) Datos registrales: T 24743 , F 191, S 8, H M 445459, I/A 10 ( 7.01.14).

  • Modificaciones Estatutarias

    Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8.

26/06/2012 Detalles del anuncio (269273) Datos registrales: T 24743 , F 190, S 8, H M 445459, I/A 9 (15.06.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: MAS CRUAÑAS MIGUEL.

  • Nombramientos

    Apoderado: BAGO I MONS RAIMON.

26/06/2012 Detalles del anuncio (269272) Datos registrales: T 24743 , F 190, S 8, H M 445459, I/A 8 (15.06.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: JANER NICOLAU ANTONI;VAZQUEZ CAMPS EUSEBI. Presidente: JANER NICOLAU ANTONI.

  • Revocaciones

    Apoderado: JANER NICOLAU ANTONI;GARCIA GASCONS JOAN.

  • Nombramientos

    Consejero: VILELLA I LLIRINOS JOSEP;SITJAS I GUELL JOSEP. Presidente: VILELLA I LLIRINOS JOSEP. Apo.Sol.: GARCIA GASCONS JOAN;VILELLA I LLIRINOS JOSEP.

12/03/2012 Detalles del anuncio (117869) Datos registrales: T 24743 , F 189, S 8, H M 445459, I/A 7 ( 1.03.12).

  • Cambio de domicilio social

    AVDA AMERICA 32 - 2& PLANTA, DESPACHO 253, FRAPEMA (ALCORCON).

24/03/2011 Detalles del anuncio (132921) Datos registrales: T 24743 , F 188, S 8, H M 445459, I/A 6 (14.03.11).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: MONTOLIU PASTOR ANTONIO;FERRER SANTAMARIA MARGARITA.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 13

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2017-228-28 30/11/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-18-28 26/01/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-177-28 15/09/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-92-28 17/05/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-146-28 04/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-9-28 15/01/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2012-120-28 26/06/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-120-28 26/06/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-50-28 12/03/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-58-28 24/03/2011 Madrid Descargar