U S P DERMOESTETICA SL

Extinta

Lokinn.com no comercialitza ni ven les dades de les empreses, només ofereix la seua informació públicament.

Si vol actualitzar-la o modificar-la registra't gratuïtament

Últims moviments

Data
Nom
Cese: 21/11/2012

USP HOSPITALES SL

Administrador único
Cese: 21/11/2012

DE ALVARO REGUERA FRANCISCO

Representante
Nombramiento: 21/11/2012

CORDON MURO MARIA ESTHER

Administrador solidario
Nombramiento: 21/11/2012

RUBIO LAPORTA JOSE RAMON

Administrador solidario
Nombramiento: 04/06/2012

SALAS MARTIN ANGEL RAMON

Apoderado
Cese: 27/02/2012

TOSANTOS BONETA LUIS GERMAN

Apoderado
Cese: 27/02/2012

LEWIS GRAEME ROBERT

Apoderado
Nombramiento: 11/08/2011

JUARROS ALCALDE MARIA JOSE

Apoderado
Cese: 14/06/2011

MATEOS GARCIA RICARDO

Apoderado
Nombramiento: 14/06/2011

LEWIS GRAEME ROBERT

Apoderado
Nombramiento: 14/06/2011

TRUJILLO CASAS JUAN RICARDO

Apoderado
Nombramiento: 14/06/2011

BARREIRO HERNANDEZ MERCEDES

Apoderado
Nombramiento: 14/06/2011

USON JAEGER PATRICIA ELIZABETH

Apoderado
Nombramiento: 14/06/2011

RICO PEREZ PEDRO CANDIDO

Apoderado
Cese: 17/11/2010

USP HOSPITALES SL

Consejero
Cese: 17/11/2010

BERRA DE UNAMUNO RAMON

Consejero
Cese: 17/11/2010

DE ALVARO REGUERA FRANCISCO

Consejero
Cese: 17/11/2010

DE ALVARO REGUERA FRANCISCO

Presidente
Cese: 17/11/2010

SALAS MARTIN ANGEL RAMON

Secretario
Cese: 17/11/2010

JIMENEZ DE LAS HERAS GEMMA ANGELA

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 17/11/2010

DE ALVARO REGUERA FRANCISCO

Representante
Nombramiento: 17/11/2010

USP HOSPITALES SL

Administrador único
Cese: 10/11/2010

BERRA DE UNAMUNO RAMON

Apoderado
Cese: 10/11/2010

MATEOS GARCIA RICARDO

Apoderado
Cese: 10/11/2010

GAMEZ SANCHEZ DANIEL

Apoderado
Cese: 10/11/2010

LANDAZURI PLAZA BEGOÑA

Apoderado
Cese: 10/11/2010

JIMENEZ DE LAS HERAS GEMMA

Apoderado
Cese: 10/11/2010

CABRERA AYALA JOSE LUIS

Apoderado
Cese: 10/11/2010

ARQUED FERNANDEZ JOSE ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

DE ALVARO REGUERA FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

DE ZULUETA GREENEBAUM JOHN

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

MATEOS GARCIA RICARDO

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

MILLAN FERNANDEZ ISAAC

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

ROMERO JIMENEZ OSCAR

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

TOSANTOS BONETA LUIS GERMAN

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

VILLARINO MARZO MARIA DEL PILAR

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

GAMEZ SANCHEZ DANIEL

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

DE JOZ SEGOVIA JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

JIMENEZ DE LAS HERAS GEMMA

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

CABRERA AYALA JOSE LUIS

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

GALA RUIZ AFRICA

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

PASTOR MORENO CRISTINA

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

COLON BOMBIN TOMAS GREGORIO

Apoderado
Cese: 22/07/2010

PRAT DOMENECH JOSE

Consejero
Cese: 22/07/2010

PRAT DOMENECH JOSE

Presidente
Nombramiento: 22/07/2010

DE ALVARO REGUERA FRANCISCO

Consejero
Nombramiento: 22/07/2010

DE ALVARO REGUERA FRANCISCO

Presidente
Cese: 12/07/2010

PRAT DOMENECH JOSE

Representante
Nombramiento: 12/07/2010

DE ALVARO REGUERA FRANCISCO

Representante
Cese: 19/05/2010

MASFURROLL LACAMBRA GABRIEL

Apoderado
Cese: 19/05/2010

ARIAS IRIGOYEN JUAN RAMON

Apoderado
Cese: 19/05/2010

JORGE NEBOT MARIA SOLEDAD

Apoderado
Cese: 19/05/2010

CALVO DEL MOLINO JUAN PEDRO

Apoderado
Cese: 19/05/2010

CURA BLASI MARIA ALBA

Apoderado
Cese: 19/05/2010

ELLAURI SANCHEZ PEDRO

Apoderado
Cese: 19/05/2010

SULTAN BENGUIGUI ESTER

Apoderado
Cese: 19/05/2010

VINYALS CASADO IGNACIO

Apoderado

Registres Mercantils relacionats

Actes mercantils publicats en l'edició digital del Registre Mercantil relacionats o inscrits per U S P DERMOESTETICA SL

28/12/2012 Detalls de l'anunci (542110) Dades registrals: T 28874 , F 105, S 8, H M 228397, I/A 39 (19.12.12).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

21/11/2012 Detalls de l'anunci (477808) Dades registrals: T 28874 , F 104, S 8, H M 228397, I/A 38 ( 8.11.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: USP HOSPITALES SL. Representan: DE ALVARO REGUERA FRANCISCO.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: CORDON MURO MARIA ESTHER;RUBIO LAPORTA JOSE RAMON.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios.

04/06/2012 Detalls de l'anunci (235587) Dades registrals: T 28874 , F 104, S 8, H M 228397, I/A 37 (23.05.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: SALAS MARTIN ANGEL RAMON.

27/02/2012 Detalls de l'anunci (93866) Dades registrals: T 28874 , F 104, S 8, H M 228397, I/A 36 (13.02.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: TOSANTOS BONETA LUIS GERMAN;LEWIS GRAEME ROBERT.

11/08/2011 Detalls de l'anunci (335175) Dades registrals: T 28874 , F 102, S 8, H M 228397, I/A 35 ( 1.08.11).

  • Nombramientos

    Apoderado: JUARROS ALCALDE MARIA JOSE.

14/06/2011 Detalls de l'anunci (254371) Dades registrals: T 13942 , F 211, S 8, H M 228397, I/A 33 ( 2.06.11).

  • Revocaciones

    Apoderado: MATEOS GARCIA RICARDO.

  • Nombramientos

    Apoderado: LEWIS GRAEME ROBERT;TRUJILLO CASAS JUAN RICARDO;BARREIRO HERNANDEZ MERCEDES;USON JAEGER PATRICIA ELIZABETH;RICO PEREZ PEDRO CANDIDO.

14/06/2011 Detalls de l'anunci (254372) Dades registrals: T 28874 , F 102, S 8, H M 228397, I/A 34 ( 3.06.11).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    UNITED SURGICAL PARTNERS MADRID SL.

17/11/2010 Detalls de l'anunci (423065) Dades registrals: T 13942 , F 211, S 8, H M 228397, I/A 32 ( 5.11.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: USP HOSPITALES SL;BERRA DE UNAMUNO RAMON;DE ALVARO REGUERA FRANCISCO. Presidente: DE ALVARO REGUERA FRANCISCO. Secretario: SALAS MARTIN ANGEL RAMON. VsecrNoConsj: JIMENEZ DE LAS HERAS GEMMA ANGELA.

  • Nombramientos

    Representan: DE ALVARO REGUERA FRANCISCO. Adm. Unico: USP HOSPITALES SL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

10/11/2010 Detalls de l'anunci (413604) Dades registrals: T 13942 , F 211, S 8, H M 228397, I/A 31 (27.10.10).

  • Revocaciones

    Apoderado: BERRA DE UNAMUNO RAMON;MATEOS GARCIA RICARDO;GAMEZ SANCHEZ DANIEL;LANDAZURI PLAZA BEGOÑA;JIMENEZ DE LAS HERAS GEMMA;CABRERA AYALA JOSE LUIS;ARQUED FERNANDEZ JOSE ANTONIO.

  • Nombramientos

    Apoderado: DE ALVARO REGUERA FRANCISCO;DE ZULUETA GREENEBAUM JOHN;MATEOS GARCIA RICARDO;MILLAN FERNANDEZ ISAAC;ROMERO JIMENEZ OSCAR;TOSANTOS BONETA LUIS GERMAN;VILLARINO MARZO MARIA DEL PILAR;GAMEZ SANCHEZ DANIEL;DE JOZ SEGOVIA JAVIER;JIMENEZ DE LAS HERAS GEMMA;CABRERA AYALA JOSE LUIS;GALA RUIZ AFRICA;PASTOR MORENO CRISTINA;COLON BOMBIN TOMAS GREGORIO.

01/10/2010 Detalls de l'anunci (728469)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2010) Año: 2009

Documents del Registre Mercantil relacionats: 17

#CVE
Data
Provincia
BORME-A-2012-248-28 28/12/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-223-28 21/11/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-104-28 04/06/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-40-28 27/02/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-153-28 11/08/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-113-28 14/06/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-113-28 14/06/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2010-220-28 17/11/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-215-28 10/11/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2010-190-28 01/10/2010 Madrid Descargar