CAPASATUS SL

Extinta

Lokinn.com no comercialitza ni ven les dades de les empreses, només ofereix la seua informació públicament.

Si vol actualitzar-la o modificar-la registra't gratuïtament

Últims moviments

Data
Nom
Cese: 06/03/2019

ROIG FARRAN TRINIDAD

Administrador concurs.
Cese: 11/12/2015

SANCLIMENS GENESCA JOSE MARIA

Consejero
Cese: 11/12/2015

SANCLIMENS GENESCA JOSE MARIA

Presidente
Cese: 11/12/2015

COPCISA SA

Consejero
Cese: 11/12/2015

CARBONELL MARCET BENITO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 11/12/2015

CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA

Consejero
Cese: 11/12/2015

ACTIVOS MACORP SL

Consejero
Cese: 11/12/2015

LOPEZ GALLEGO ANTONIO

Secretario no consejero
Cese: 11/12/2015

PEREZ ROVIRA JORGE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 11/12/2015

CARTAGENA VIME ROGER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 20/02/2014

ROIG FARRAN TRINIDAD

Administrador concurs.
Cese: 26/02/2013

GALLART SULLA EDUARD

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 26/02/2013

CARTAGENA VIME ROGER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 08/08/2012

BORDAS BERNAT LLUIS

Consejero
Cese: 08/08/2012

REYNER SERRA JOSEP

Consejero
Cese: 08/08/2012

RIVEIRO LOPEZ NIÑO ALFONSO

Secretario no consejero
Cese: 08/08/2012

BORDAS BERNAT LUIS

Apoderado
Cese: 08/08/2012

BALAÑA PARRA JORDI

Apoderado
Nombramiento: 08/08/2012

CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA

Consejero
Nombramiento: 08/08/2012

ACTIVOS MACORP SL

Consejero
Nombramiento: 08/08/2012

LOPEZ GALLEGO ANTONIO

Secretario no consejero
Nombramiento: 08/08/2012

PEREZ ROVIRA JORGE

Apoderado
Nombramiento: 08/08/2012

PLANA FARIN ALEJANDRO

Apoderado
Nombramiento: 08/08/2012

PEREZ ROVIRA JORGE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 08/08/2012

GALLART SULLA EDUARD

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 07/08/2012

CARBONELL MARCET BENITO

Consejero
Nombramiento: 07/08/2012

COPCISA SA

Consejero
Nombramiento: 07/08/2012

CARBONELL MARCET BENITO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 11/12/2009

SANCLIMENS GENESCA JOSE MARIA

Consejero delegado
Nombramiento: 11/12/2009

BORDAS BERNAT LUIS

Apoderado
Nombramiento: 11/12/2009

BALAÑA PARRA JORDI

Apoderado
Nombramiento: 11/12/2009

SANCLIMENS GENESCA JOSEP MARIA

Apoderado
Cese: 11/12/2009

NAVARRO CLIMENT JOSEP

Consejero
Cese: 11/12/2009

NAVARRO CLIMENT JOSEP

Secretario
Nombramiento: 11/12/2009

REYNER SERRA JOSEP

Consejero
Nombramiento: 11/12/2009

RIVEIRO LOPEZ NIÑO ALFONSO

Secretario no consejero

Registres Mercantils relacionats

Actes mercantils publicats en l'edició digital del Registre Mercantil relacionats o inscrits per CAPASATUS SL

06/03/2019 Detalls de l'anunci (103462) Dades registrals: T 43293 , F 175, S 8, H B 244851, I/A 13 (27.02.19).

  • Revocaciones

    ADM.CONCURS.: ROIG FARRAN TRINIDAD.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 680/2013, AUTO FIRME DE FECHA 14/12/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD.

  • Extinción

22/02/2016 Detalls de l'anunci (77746) Dades registrals: T 43293 , F 175, S 8, H B 244851, I/A 12 (15.02.16).

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 680/2013, AUTO FIRME DE FECHA 15/01/2016, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD.

11/12/2015 Detalls de l'anunci (501238) Dades registrals: T 43293 , F 173, S 8, H B 244851, I/A 11 ( 1.12.15).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: SANCLIMENS GENESCA JOSE MARIA. PRESIDENTE: SANCLIMENS GENESCA JOSE MARIA. CONSEJERO: COPCISA SA. REPR.143 RRM: CARBONELL MARCET BENITO. CONSEJERO: CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA;ACTIVOS MACORP SL. SECR.NO CONS: LOPEZ GALLEGO ANTONIO. REPR.143 RRM: PEREZ ROVIRA JORGE;CARTAGENA VIME ROGER.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 680/2013, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 27/04/2015 Y 13/07/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

  • Disolución

    Judicial.

20/02/2014 Detalls de l'anunci (79630) Dades registrals: T 43293 , F 172, S 8, H B 244851, I/A 10 (12.02.14).

  • Nombramientos

    ADM.CONCURS.: ROIG FARRAN TRINIDAD.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 680/2013, AUTO FIRME DE FECHA 05/11/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.

26/02/2013 Detalls de l'anunci (94901) Dades registrals: T 43293 , F 171, S 8, H B 244851, I/A 9 (18.02.13).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: GALLART SULLA EDUARD.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: CARTAGENA VIME ROGER.

08/08/2012 Detalls de l'anunci (332947) Dades registrals: T 43293 , F 171, S 8, H B 244851, I/A 8 (26.07.12).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: BORDAS BERNAT LLUIS;REYNER SERRA JOSEP. SECR.NO CONS: RIVEIRO LOPEZ NIÑO ALFONSO. APODERADO: BORDAS BERNAT LUIS;BALAÑA PARRA JORDI.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA;ACTIVOS MACORP SL. SECR.NO CONS: LOPEZ GALLEGO ANTONIO. APODERADO: PEREZ ROVIRA JORGE;PLANA FARIN ALEJANDRO. REPR.143 RRM: PEREZ ROVIRA JORGE;GALLART SULLA EDUARD.

07/08/2012 Detalls de l'anunci (330426) Dades registrals: T 34203 , F 42, S 8, H B 244851, I/A 7 (26.07.12).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: CARBONELL MARCET BENITO.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: COPCISA SA. REPR.143 RRM: CARBONELL MARCET BENITO.

29/10/2010 Detalls de l'anunci (920676)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2010) Año: 2009

27/01/2010 Detalls de l'anunci (60011)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Diciembre de 2009) Año: 2008

11/12/2009 Detalls de l'anunci (516376) Dades registrals: T 34203 , F 41, S 8, H B 244851, I/A 6 (30.11.09).

  • Revocaciones

    CONS. DELEG.: SANCLIMENS GENESCA JOSE MARIA.

  • Nombramientos

    APODERADO: BORDAS BERNAT LUIS;BALAÑA PARRA JORDI;SANCLIMENS GENESCA JOSEP MARIA.

Documents del Registre Mercantil relacionats: 11

#CVE
Data
Provincia
BORME-A-2019-45-08 06/03/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-35-08 22/02/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-236-08 11/12/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-35-08 20/02/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-39-08 26/02/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-151-08 08/08/2012 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-150-08 07/08/2012 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-209-08 29/10/2010 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-17-08 27/01/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-236-08 11/12/2009 Barcelona Descargar