BAOLAB MICROSYSTEMS SL

Extinta

Lokinn.com no comercialitza ni ven les dades de les empreses, només ofereix la seua informació públicament.

Si vol actualitzar-la o modificar-la registra't gratuïtament

Últims moviments

Data
Nom
Cese: 25/05/2016

FOREST PARTNERS ESTRADA Y ASOCIADOS SLP

Administrador concurs.
Cese: 25/05/2016

MATAS TORRELLAS JORGE

Representante administrador concurs.
Cese: 14/08/2015

CONDE MORAGUES MANUEL

Consejero
Cese: 14/08/2015

TODA JIMENEZ CARLOS MARIA

Consejero
Cese: 14/08/2015

LEMUS TOMAS FERRAN

Consejero
Cese: 14/08/2015

LEMUS TOMAS FERRAN

Vicepresidente
Cese: 14/08/2015

ARIAS GABASA FELIX

Consejero
Cese: 14/08/2015

REÑAGA RUBIN CARMEN

Secretario no consejero
Cese: 14/08/2015

MONTOBBIO MARTORELL FERNANDO

Vicesecretario no consejero
Cese: 14/08/2015

HIGHGROWTH PARTNERS SGECR SA

Consejero
Cese: 14/08/2015

ROSELLO MENASANCH JOSE LUIS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 25/06/2014

FOREST PARTNERS ESTRADA Y ASOCIADOS SLP

Administrador concurs.
Nombramiento: 25/06/2014

MATAS TORRELLAS JORGE

Representante administrador concurs.
Cese: 06/06/2014

MAJO CRUZATE JOAN

Consejero
Cese: 06/06/2014

MAJO CRUZATE JOAN

Presidente
Cese: 12/05/2014

MONTANYA SILVESTRE JOSEP

Consejero
Cese: 12/05/2014

MONTANYA SILVESTRE JOSEP

Apoderado
Cese: 10/03/2014

DAVE DOYLE

Consejero
Cese: 11/12/2012

CONDE MORAGUES MANUEL

Consejero delegado
Nombramiento: 11/12/2012

ARIAS GABASA FELIX

Apoderado
Nombramiento: 11/12/2012

LEMUS TOMAS FERRAN

Apoderado
Cese: 11/12/2012

TODA JIMENEZ CARLOS MARIA

Apoderado
Nombramiento: 25/09/2012

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 22/08/2011

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 16/08/2010

BDO AUDIBERIA AUDITORES SL

Auditor de cuentas

Registres Mercantils relacionats

Actes mercantils publicats en l'edició digital del Registre Mercantil relacionats o inscrits per BAOLAB MICROSYSTEMS SL

25/05/2016 Detalls de l'anunci (220409) Dades registrals: T 44333 , F 63, S 8, H B 268235, I/A 34 (17.05.16).

  • Revocaciones

    ADM.CONCURS.: FOREST PARTNERS ESTRADA Y ASOCIADOS SLP. REP.ADM.CONC: MATAS TORRELLAS JORGE.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 285/2014, AUTO FIRME DE FECHA 15/04/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.

  • Extinción

17/08/2015 Detalls de l'anunci (340054) Dades registrals: T 44333 , F 63, S 8, H B 268235, I/A 33 (10.08.15).

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 285/2014, AUTO FIRME DE FECHA 18/06/2015, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO.

17/08/2015 Detalls de l'anunci (340053) Dades registrals: T 44333 , F 62, S 8, H B 268235, I/A 32 (10.08.15).

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 285/2014, AUTO FIRME DE FECHA 22/01/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

14/08/2015 Detalls de l'anunci (338486) Dades registrals: T 44333 , F 62, S 8, H B 268235, I/A 31 (10.08.15).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: CONDE MORAGUES MANUEL;TODA JIMENEZ CARLOS MARIA;LEMUS TOMAS FERRAN. VICEPRESIDEN: LEMUS TOMAS FERRAN. CONSEJERO: ARIAS GABASA FELIX. SECR.NO CONS: REÑAGA RUBIN CARMEN. V- SEC NO CON: MONTOBBIO MARTORELL FERNANDO. CONSEJERO: HIGHGROWTH PARTNERS SGECR SA. REPR.143 RRM: ROSELLO MENASANCH JOSE LUIS.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 285/2014, AUTO FIRME DE FECHA 19/09/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

  • Disolución

    Judicial.

25/06/2014 Detalls de l'anunci (262000) Dades registrals: T 44333 , F 61, S 8, H B 268235, I/A 30 (17.06.14).

  • Nombramientos

    ADM.CONCURS.: FOREST PARTNERS ESTRADA Y ASOCIADOS SLP. REP.ADM.CONC: MATAS TORRELLAS JORGE.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 285/2014, AUTO FIRME DE FECHA 20/05/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.

06/06/2014 Detalls de l'anunci (238611) Dades registrals: T 42045 , F 20, S 8, H B 268235, I/A 29 (29.05.14).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: MAJO CRUZATE JOAN. PRESIDENTE: MAJO CRUZATE JOAN.

12/05/2014 Detalls de l'anunci (197592) Dades registrals: T 42045 , F 20, S 8, H B 268235, I/A 28 (29.04.14).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: MONTANYA SILVESTRE JOSEP. APODERADO: MONTANYA SILVESTRE JOSEP.

10/03/2014 Detalls de l'anunci (107690) Dades registrals: T 42045 , F 20, S 8, H B 268235, I/A 27 (28.02.14).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: DAVE DOYLE.

11/06/2013 Detalls de l'anunci (266492) Dades registrals: T 42045 , F 20, S 8, H B 268235, I/A 26 ( 4.06.13).

  • Modificaciones Estatutarias

    ARTS.15 Y 17.- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL.

  • Página web de la sociedad

    Creación de la página web corporativa: www.baolab.com.

11/12/2012 Detalls de l'anunci (511050) Dades registrals: T 42045 , F 18, S 8, H B 268235, I/A 25 (30.11.12).

  • Revocaciones

    CONS. DELEG.: CONDE MORAGUES MANUEL.

  • Nombramientos

    APODERADO: ARIAS GABASA FELIX;LEMUS TOMAS FERRAN.

  • Modificación de poderes

    APODERADO: TODA JIMENEZ CARLOS MARIA.

Documents del Registre Mercantil relacionats: 22

#CVE
Data
Provincia
BORME-A-2016-98-08 25/05/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-155-08 17/08/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-155-08 17/08/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-154-08 14/08/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-118-08 25/06/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-106-08 06/06/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-88-08 12/05/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-47-08 10/03/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-108-08 11/06/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-236-08 11/12/2012 Barcelona Descargar