VERTICALES INTERCOM SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 26/02/2019 | TABARES MONTOYA BEATRIZ |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 26/02/2019 | GARCIA CARBAJOSA ELISA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 26/02/2019 | ZAVALA AZOR FERNANDO JOSE |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 16/11/2018 | VIVES MAS ESTUDIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL |
Auditor de cuentas |
| Nombramiento: 20/08/2018 | ONESEVEN AUDITORIA CONSULTORIA SL |
Auditor de cuentas |
| Cese: 22/05/2018 | BALDRICH MARTIN FRANCESC XAVIER |
Consejero |
| Cese: 22/05/2018 | LLORENTE MORAL FRANCISCO JAVIER |
Consejero |
| Cese: 20/02/2018 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Consejero |
| Cese: 20/02/2018 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Presidente |
| Cese: 20/02/2018 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 20/02/2018 | BONSAI VENTURE CAPITAL SCR SA |
Consejero |
| Nombramiento: 20/02/2018 | CEBRIAN MONEREO FRANCISCO JAVIER |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 20/02/2018 | SILPRICOT SL |
Consejero |
| Nombramiento: 20/02/2018 | SILPRICOT SL |
Presidente |
| Nombramiento: 20/02/2018 | SILPRICOT SL |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 20/02/2018 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 09/03/2017 | ZAVALA AZOR FERNANDO JOSE |
Apoderado solidario |
| Cese: 12/01/2016 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Administrador único |
| Nombramiento: 12/01/2016 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Consejero |
| Nombramiento: 12/01/2016 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Presidente |
| Nombramiento: 12/01/2016 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 12/01/2016 | ZAVALA AZOR FERNANDO |
Consejero |
| Nombramiento: 12/01/2016 | BALDRICH MARTIN FRANCESC XAVIER |
Consejero |
| Nombramiento: 12/01/2016 | LLORENTE MORAL FRANCISCO JAVIER |
Consejero |
| Nombramiento: 12/01/2016 | GRUPO INTERCOM DE CAPITAL SCR PYME SA |
Consejero |
| Nombramiento: 12/01/2016 | GONZALEZ BARROS BELLSOLA ANTONIO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 12/01/2016 | GARCIA BO JORDI |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 05/09/2014 | VIVES MAS ESTUDIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL |
Auditor de cuentas |
| Cese: 16/04/2014 | SANCHEZ MARTIN ANTONIO IGNACIO |
Apoderado |
| Cese: 16/04/2014 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Apoderado |
| Nombramiento: 16/04/2014 | MEDINA ROBLES DIVINA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 16/04/2014 | GARCIA BO JORDI |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 16/04/2014 | MATIAS HERRERO MAGALI |
Apoderado solidario |
| Cese: 19/03/2014 | INTERCOM FACTORY SL |
Administrador único |
| Cese: 19/03/2014 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 19/03/2014 | FERRER PUJOL JOSE LUIS |
Administrador único |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por VERTICALES INTERCOM SL
02/08/2021 Detalles del anuncio (364657) Datos registrales: T 45827 , F 28, S 8, H B 360009, I/A 22 (23.07.21).
30/07/2019 Detalles del anuncio (330724) Datos registrales: T 45827 , F 27, S 8, H B 360009, I/A 21 (23.07.19).
- Ampliación de Capital
Capital: 96.525,00 Euros. Resultante Suscrito: 148.500,00 Euros.
30/07/2019 Detalles del anuncio (330722) Datos registrales: T 45827 , F 25, S 8, H B 360009, I/A 20 (23.07.19).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 96.525,00 Euros. Resultante Suscrito: 51.975,00 Euros.
- Escisión Parcial
Sociedades beneficiarias de la escisión: THE MIND HUB COMPANY S.L.
16/04/2019 Detalles del anuncio (427)
- Depósitos de proyectos de escisión parcial
26/02/2019 Detalles del anuncio (89062) Datos registrales: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 19 (14.02.19).
- Nombramientos
APODERAD.SOL: TABARES MONTOYA BEATRIZ;GARCIA CARBAJOSA ELISA;ZAVALA AZOR FERNANDO JOSE.
16/11/2018 Detalles del anuncio (456379) Datos registrales: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 18 ( 7.11.18).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: VIVES MAS ESTUDIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL.
06/11/2018 Detalles del anuncio (442079) Datos registrales: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 17 (25.10.18).
- Cambio de domicilio social
AV ALCALDE BARNILS NUM.64-68 MODULO D P.1 (SANT CUGAT DEL VALLES).
20/08/2018 Detalles del anuncio (342506) Datos registrales: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 16 (10.08.18).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: ONESEVEN AUDITORIA CONSULTORIA SL.
22/05/2018 Detalles del anuncio (214382) Datos registrales: T 45827 , F 22, S 8, H B 360009, I/A 15 (10.05.18).
- Revocaciones
CONSEJERO: BALDRICH MARTIN FRANCESC XAVIER;LLORENTE MORAL FRANCISCO JAVIER.
20/02/2018 Detalles del anuncio (81673) Datos registrales: T 45827 , F 21, S 8, H B 360009, I/A 14 (12.02.18).
- Revocaciones
CONSEJERO: FERRER PUJOL JOSE LUIS. PRESIDENTE: FERRER PUJOL JOSE LUIS. CONS. DELEG.: FERRER PUJOL JOSE LUIS.
- Nombramientos
CONSEJERO: BONSAI VENTURE CAPITAL SCR SA. REPR.143 RRM: CEBRIAN MONEREO FRANCISCO JAVIER. CONSEJERO: SILPRICOT SL. PRESIDENTE: SILPRICOT SL. CONS. DELEG.: SILPRICOT SL. REPR.143 RRM: FERRER PUJOL JOSE LUIS.
- Modificaciones Estatutarias
MODIFICACION DEL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 24
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2021-146-08 | 02/08/2021 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-144-08 | 30/07/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-144-08 | 30/07/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-B-2019-74-08 | 16/04/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-39-08 | 26/02/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-220-08 | 16/11/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-213-08 | 06/11/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-159-08 | 20/08/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-96-08 | 22/05/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-36-08 | 20/02/2018 | Barcelona | Descargar |