THIRD ROUND SL

Activa

CTRA GIJON SEVILLA Km 154 (ONZONILLA).
 Onzonilla, León
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 22/05/2023

EUDITA CENSORS JURIES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA

Auditor
Nombramiento: 22/05/2023

ADN ALVAREZ Y ASOCIADOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD

Auditor
Nombramiento: 26/09/2022

EUDITA CENSORS JURIES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA

Auditor
Cese: 17/01/2017

ROBERTO HERRERO PABLO

Consejero
Cese: 17/01/2017

ROBERTO HERRERO PABLO

Secretario
Cese: 17/01/2017

CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL

Consejero delegado mancomunado solidario
Cese: 17/01/2017

CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL

Presidente
Cese: 17/01/2017

CARRO DE LUCIO HUGO

Vicepresidente
Cese: 17/01/2017

CARRO DE LUCIO GUILLERMINA

Vicesecretario
Cese: 17/01/2017

CARRO DE LUCIO HUGO

Consejero delegado
Nombramiento: 17/01/2017

OSORIO GONZALEZ PEDRO MANUEL

Consejero
Nombramiento: 17/01/2017

CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL

Presidente
Nombramiento: 17/01/2017

CARRO DE LUCIO HUGO

Vicepresidente
Nombramiento: 17/01/2017

CARRO DE LUCIO GUILLERMINA

Secretario
Nombramiento: 17/01/2017

OSORIO GONZALEZ PEDRO MANUEL

Vicesecretario
Nombramiento: 17/01/2017

CARRO DE LUCIO HUGO

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 17/01/2017

OSORIO GONZALEZ PEDRO MANUEL

Consejero delegado mancomunado solidario
Cese: 14/12/2015

SANTOS SERRANO JULIAN

Consejero
Cese: 14/12/2015

SANTOS SERRANO JULIAN

Secretario
Cese: 14/12/2015

SANTOS SERRANO JULIAN

Consejero delegado
Nombramiento: 14/12/2015

ROBERTO HERRERO PABLO

Consejero
Nombramiento: 14/12/2015

ROBERTO HERRERO PABLO

Secretario
Nombramiento: 14/12/2015

CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 14/12/2015

CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL

Presidente
Nombramiento: 14/12/2015

CARRO DE LUCIO HUGO

Vicepresidente
Nombramiento: 14/12/2015

CARRO DE LUCIO GUILLERMINA

Vicesecretario
Nombramiento: 14/12/2015

CARRO DE LUCIO HUGO

Consejero delegado
Nombramiento: 11/11/2014

CARRO DE LUCIO HUGO

Consejero
Nombramiento: 11/11/2014

CARRO DE LUCIO GUILLERMINA

Consejero
Nombramiento: 11/11/2014

CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL

Consejero
Nombramiento: 11/11/2014

SANTOS SERRANO JULIAN

Consejero
Nombramiento: 11/11/2014

CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL

Presidente
Nombramiento: 11/11/2014

CARRO DE LUCIO HUGO

Vicepresidente
Nombramiento: 11/11/2014

SANTOS SERRANO JULIAN

Secretario
Nombramiento: 11/11/2014

CARRO DE LUCIO GUILLERMINA

Vicesecretario
Nombramiento: 11/11/2014

CARRO DE LUCIO HUGO

Consejero delegado
Nombramiento: 11/11/2014

SANTOS SERRANO JULIAN

Consejero delegado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por THIRD ROUND SL

22/05/2023 Detalles del anuncio (231207) Datos registrales: T 1281 , F 216, S 8, H LE 23123, I/A 7 (15.05.23).

  • Cancelaciones de oficio de nombramientos

    Auditor: EUDITA CENSORS JURIES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA.

  • Nombramientos

    Auditor: ADN ALVAREZ Y ASOCIADOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD.

26/09/2022 Detalles del anuncio (426449) Datos registrales: T 1281 , F 216, S 8, H LE 23123, I/A 6 (20.09.22).

  • Nombramientos

    Auditor: EUDITA CENSORS JURIES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA.

26/09/2017 Detalles del anuncio (383244) Datos registrales: T 1281 , F 215, S 8, H LE 23123, I/A 5 (19.09.17).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 50.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 63.000,00 Euros.

17/01/2017 Detalles del anuncio (23030) Datos registrales: T 1281 , F 215, S 8, H LE 23123, I/A 4 (11.01.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ROBERTO HERRERO PABLO. Secretario: ROBERTO HERRERO PABLO. Co.De.Ma.So: CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL. Presidente: CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL. Vicepresid.: CARRO DE LUCIO HUGO. Vicesecret.: CARRO DE LUCIO GUILLERMINA. Con.Delegado: CARRO DE LUCIO HUGO.

  • Nombramientos

    Consejero: OSORIO GONZALEZ PEDRO MANUEL. Presidente: CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL. Vicepresid.: CARRO DE LUCIO HUGO. Secretario: CARRO DE LUCIO GUILLERMINA. Vicesecret.: OSORIO GONZALEZ PEDRO MANUEL. Co.De.Ma.So: CARRO DE LUCIO HUGO;OSORIO GONZALEZ PEDRO MANUEL.

  • Cambio de domicilio social

    CTRA GIJON SEVILLA Km 154 (ONZONILLA).

14/12/2015 Detalles del anuncio (505132) Datos registrales: T 1281 , F 214, S 8, H LE 23123, I/A 3 ( 4.12.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: SANTOS SERRANO JULIAN. Secretario: SANTOS SERRANO JULIAN. Con.Delegado: SANTOS SERRANO JULIAN.

  • Nombramientos

    Consejero: ROBERTO HERRERO PABLO. Secretario: ROBERTO HERRERO PABLO. Co.De.Ma.So: CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL.

  • Reelecciones

    Presidente: CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL. Vicepresid.: CARRO DE LUCIO HUGO. Vicesecret.: CARRO DE LUCIO GUILLERMINA. Con.Delegado: CARRO DE LUCIO HUGO.

28/09/2015 Detalles del anuncio (390108) Datos registrales: T 1281 , F 213, S 8, H LE 23123, I/A 2 (22.09.15).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.000,00 Euros.

11/11/2014 Detalles del anuncio (455255) Datos registrales: T 1281 , F 212, S 8, H LE 23123, I/A 1 ( 3.11.14).

  • Constitución

    Comienzo de operaciones: 10.10.14. Objeto social: El código CNAE de la actividad principal es el 4615. A).-La compraventa, importación-exportación y distribución tanto a nivel nacional como internacional de artículos de regalo, bisutería, decoración, menaje, mueble. Domicilio: C/ EL HOSPICIO 4 (LEON). Capital: 3.000,00 Euros.

  • Nombramientos

    Consejero: CARRO DE LUCIO HUGO;CARRO DE LUCIO GUILLERMINA;CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL;SANTOS SERRANO JULIAN. Presidente: CREGO RODRIGUEZ JOSE ANGEL. Vicepresid.: CARRO DE LUCIO HUGO. Secretario: SANTOS SERRANO JULIAN. Vicesecret.: CARRO DE LUCIO GUILLERMINA. Con.Delegado: CARRO DE LUCIO HUGO;SANTOS SERRANO JULIAN.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 7

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2023-94-24 22/05/2023 León Descargar
BORME-A-2022-184-24 26/09/2022 León Descargar
BORME-A-2017-184-24 26/09/2017 León Descargar
BORME-A-2017-11-24 17/01/2017 León Descargar
BORME-A-2015-237-24 14/12/2015 León Descargar
BORME-A-2015-185-24 28/09/2015 León Descargar
BORME-A-2014-215-24 11/11/2014 León Descargar