STEIN VON LIEBIG BALEARS XVIII SL

Extinta

C/ JENNER 3 - PLANTA 4ª (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 02/08/2019

GIMENEZ SORIANO PABLO

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/08/2019

OLAGUIBEL AMICH IÑIGO

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/08/2019

VALENCIA MUÑOZ PABLO

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/08/2019

PEREZ MARCOS OSCAR

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/08/2019

ASUERO RESUSTA VICENTE

Apoderado solidario
Cese: 31/07/2019

DIF MANAGEMENT SPAIN SL

Administrador mancomunado
Cese: 31/07/2019

DIF MANAGEMENT FRANCE SARL

Administrador mancomunado
Cese: 31/07/2019

BERRUECO GONZALEZ RAUL

Representante
Cese: 31/07/2019

MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO

Representante
Nombramiento: 31/07/2019

Q-ENERGY ILMENITA SL

Administrador único
Nombramiento: 31/07/2019

PAREJO DEL RIO DANIEL

Representante
Cese: 04/05/2017

VIEILLESCAZES THOMAS CHARLES

Representante
Nombramiento: 04/05/2017

MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO

Representante
Cese: 11/03/2014

TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT BV

Administrador único
Cese: 11/03/2014

BENDITO PRIETO CARLOS

Representante
Nombramiento: 11/03/2014

VIEILLESCAZES THOMAS CHARLES

Representante
Nombramiento: 11/03/2014

VIEILLESCAZES THOMAS CHARLES

Representante
Nombramiento: 11/03/2014

DIF MANAGEMENT SPAIN SL

Administrador mancomunado
Nombramiento: 11/03/2014

DIF MANAGEMENT FRANCE SARL

Administrador mancomunado
Cese: 09/08/2010

STEIN VON LIEBIG INES EUGENIA

Administrador único
Nombramiento: 09/08/2010

TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT BV

Administrador único

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por STEIN VON LIEBIG BALEARS XVIII SL

11/10/2019 Detalles del anuncio (423257) Datos registrales: T 28140 , F 206, S 8, H M 506956, I/A 7 ( 4.10.19).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

02/08/2019 Detalles del anuncio (338765) Datos registrales: T 28140 , F 203, S 8, H M 506956, I/A 6 (26.07.19).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: GIMENEZ SORIANO PABLO;OLAGUIBEL AMICH IÑIGO;VALENCIA MUÑOZ PABLO;PEREZ MARCOS OSCAR;ASUERO RESUSTA VICENTE.

31/07/2019 Detalles del anuncio (333466) Datos registrales: T 28140 , F 202, S 8, H M 506956, I/A 5 (24.07.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: DIF MANAGEMENT SPAIN SL;DIF MANAGEMENT FRANCE SARL. Representan: BERRUECO GONZALEZ RAUL;MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: Q-ENERGY ILMENITA SL. Representan: PAREJO DEL RIO DANIEL.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único.

  • Cambio de domicilio social

    C/ JENNER 3 - PLANTA 4ª (MADRID).

  • Cambio de objeto social

    EL DESARROLLO Y PROMOCION DE PROYECTOS ENERGETICOS, LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, SUMINISTRO Y COMERCIALIZACION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA.

04/05/2017 Detalles del anuncio (186878) Datos registrales: T 28140 , F 202, S 8, H M 506956, I/A 4 (20.04.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: VIEILLESCAZES THOMAS CHARLES.

  • Nombramientos

    Representan: MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO.

25/11/2014 Detalles del anuncio (479813) Datos registrales: T 28140 , F 201, S 8, H M 506956, I/A 3 (28.02.14).

  • Fe de erratas

    SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 3& EL NOMBRAMIENTO 2 VECES COMO REPRESENTANTE DE VIEILLESCAZES THOMAS CHARLES, SIENDO LO CORRECTO UNO DE ELLOS BERRUECO GONZALEZ RAUL.

11/03/2014 Detalles del anuncio (110552) Datos registrales: T 28140 , F 201, S 8, H M 506956, I/A 3 (28.02.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT BV. Representan: BENDITO PRIETO CARLOS.

  • Nombramientos

    Representan: VIEILLESCAZES THOMAS CHARLES;VIEILLESCAZES THOMAS CHARLES. Adm. Mancom.: DIF MANAGEMENT SPAIN SL;DIF MANAGEMENT FRANCE SARL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados.

  • Cambio de domicilio social

    C/ ANTONIO MAURA 10 2º (MADRID).

07/10/2011 Detalles del anuncio (744137)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2011) Año: 2010

07/02/2011 Detalles del anuncio (62518)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Enero de 2011) Año: 2009

20/10/2010 Detalles del anuncio (388992) Datos registrales: T 28140 , F 200, S 8, H M 506956, I/A 2 ( 7.10.10).

  • Cambio de domicilio social

    C/ JOSE ECHEGARAY 5 - PARQUE EMPRESARIAL LAS ROZAS (ROZAS DE MADRID (LAS)).

09/08/2010 Detalles del anuncio (311474) Datos registrales: T 2298 , F 12, S 8, H PM 59656, I/A 3 (24.07.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: STEIN VON LIEBIG INES EUGENIA.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT BV.

  • Otros Conceptos

    Sucesivos cambios de la denominación del socio único, pasando a denominarse en la actualidad: Murcia Solar Park Gmbh.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2019-196-28 11/10/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-147-28 02/08/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-145-28 31/07/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2017-83-28 04/05/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2014-225-28 25/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-48-28 11/03/2014 Madrid Descargar
BORME-B-2011-192-28 07/10/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2011-25-28 07/02/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2010-202-28 20/10/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-151-07 09/08/2010 Balears, Illes Descargar