SOLVASA SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 27/02/2018 | GESTIHOTELS ALEGRIA SL |
Apoderado solidario |
| Cese: 08/04/2015 | VALLS LLORET JOSE DOMINGO |
Administrador solidario |
| Cese: 08/04/2015 | SERRANO GONZALEZ RAFAEL |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 08/04/2015 | SERRANO GONZALEZ RAFAEL |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 08/04/2015 | PASCUAL COMAS JOAN |
Administrador solidario |
| Cese: 18/11/2014 | VALLS LLORET JOSE DOMINGO |
Administrador solidario |
| Cese: 18/11/2014 | SERRANO GONZALEZ RAFAEL |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 18/11/2014 | VALLS LLORET JOSE DOMINGO |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 18/11/2014 | SERRANO GONZALEZ RAFAEL |
Administrador solidario |
| Cese: 23/01/2013 | SEGURA OLIVARES CONSUELO |
Consejero |
| Cese: 23/01/2013 | RECIO JURADO DOLORES |
Consejero |
| Cese: 23/01/2013 | RECIO JURADO DOLORES |
Secretario |
| Cese: 23/01/2013 | RECIO JURADO ISIDORO |
Consejero |
| Cese: 23/01/2013 | RECIO JURADO ISIDORO |
Presidente |
| Nombramiento: 23/01/2013 | VALLS LLORET JOSE DOMINGO |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 23/01/2013 | SERRANO GONZALEZ RAFAEL |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 23/01/2013 | FERGUS HOTELS SL |
Apoderado |
| Cese: 16/12/2011 | RECIO GOMEZ JUAN |
Consejero |
| Cese: 16/12/2011 | RECIO GOMEZ JUAN |
Presidente |
| Cese: 16/12/2011 | RECIO JURADO DOLORES |
Consejero |
| Cese: 16/12/2011 | RECIO JURADO DOLORES |
Secretario |
| Cese: 16/12/2011 | RECIO JURADO ISIDORO |
Consejero |
| Cese: 16/12/2011 | SEGURA OLIVARES CONSUELO |
Consejero |
| Nombramiento: 16/12/2011 | SEGURA OLIVARES CONSUELO |
Consejero |
| Nombramiento: 16/12/2011 | RECIO JURADO DOLORES |
Consejero |
| Nombramiento: 16/12/2011 | RECIO JURADO DOLORES |
Secretario |
| Nombramiento: 16/12/2011 | RECIO JURADO ISIDORO |
Consejero |
| Nombramiento: 16/12/2011 | RECIO JURADO ISIDORO |
Presidente |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SOLVASA SL
12/02/2019 Detalles del anuncio (63241) Datos registrales: T 22199 , F 47, S 8, H B 113691, I/A 27 ( 4.02.19).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 15.540,00 Euros. Resultante Suscrito: 341.418,00 Euros.
27/02/2018 Detalles del anuncio (92513) Datos registrales: T 22199 , F 46, S 8, H B 113691, I/A 26 (16.02.18).
- Nombramientos
APODERAD.SOL: GESTIHOTELS ALEGRIA SL.
25/01/2018 Detalles del anuncio (38493) Datos registrales: T 22199 , F 46, S 8, H B 113691, I/A 25 (16.01.18).
- Ampliación de Capital
Capital: 46.374,00 Euros. Resultante Suscrito: 356.958,00 Euros.
08/04/2015 Detalles del anuncio (145510) Datos registrales: T 22199 , F 46, S 8, H B 113691, I/A 24 (30.03.15).
- Revocaciones
ADM.SOLIDAR.: VALLS LLORET JOSE DOMINGO;SERRANO GONZALEZ RAFAEL.
- Nombramientos
ADM.SOLIDAR.: SERRANO GONZALEZ RAFAEL;PASCUAL COMAS JOAN.
18/11/2014 Detalles del anuncio (467192) Datos registrales: T 7424 , F 175, S 8, H B 113691, I/A 23 (10.11.14).
- Transformación de Sociedad
Denominación y forma adoptada: SOLVASA SL.
- Revocaciones
ADM.SOLIDAR.: VALLS LLORET JOSE DOMINGO;SERRANO GONZALEZ RAFAEL.
- Nombramientos
ADM.SOLIDAR.: VALLS LLORET JOSE DOMINGO;SERRANO GONZALEZ RAFAEL.
12/08/2013 Detalles del anuncio (358544) Datos registrales: T 7424 , F 174, S 8, H B 113691, I/A 21 ( 1.08.13).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 445,33 Euros. Resultante Suscrito: 264.000,00 Euros.
12/08/2013 Detalles del anuncio (358545) Datos registrales: T 7424 , F 174, S 8, H B 113691, I/A 22 ( 1.08.13).
- Ampliación de Capital
Suscrito: 46.584,00 Euros. Desembolsado: 46.584,00 Euros. Resultante Suscrito: 310.584,00 Euros. Resultante Desembolsado: 310.584,00 Euros.
23/01/2013 Detalles del anuncio (32877) Datos registrales: T 7424 , F 173, S 8, H B 113691, I/A 19 (15.01.13).
- Revocaciones
CONSEJERO: SEGURA OLIVARES CONSUELO;RECIO JURADO DOLORES. SECRETARIO: RECIO JURADO DOLORES. CONSEJERO: RECIO JURADO ISIDORO. PRESIDENTE: RECIO JURADO ISIDORO.
- Nombramientos
ADM.SOLIDAR.: VALLS LLORET JOSE DOMINGO;SERRANO GONZALEZ RAFAEL.
- Modificaciones Estatutarias
MODIFICACION ARTS.13,23,PRIMER PARRAFO DEL ART.26,27 Y SUPRESION ART.28:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.
23/01/2013 Detalles del anuncio (32866) Datos registrales: T 7424 , F 174, S 8, H B 113691, I/A 20 (15.01.13).
- Nombramientos
APODERADO: FERGUS HOTELS SL.
16/12/2011 Detalles del anuncio (499623) Datos registrales: T 7424 , F 173, S 8, H B 113691, I/A 18 ( 5.12.11).
- Revocaciones
CONSEJERO: RECIO GOMEZ JUAN. PRESIDENTE: RECIO GOMEZ JUAN. CONSEJERO: RECIO JURADO DOLORES. SECRETARIO: RECIO JURADO DOLORES. CONSEJERO: RECIO JURADO ISIDORO;SEGURA OLIVARES CONSUELO.
- Nombramientos
CONSEJERO: SEGURA OLIVARES CONSUELO;RECIO JURADO DOLORES. SECRETARIO: RECIO JURADO DOLORES. CONSEJERO: RECIO JURADO ISIDORO. PRESIDENTE: RECIO JURADO ISIDORO.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 13
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2019-29-08 | 12/02/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-41-08 | 27/02/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-18-08 | 25/01/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-65-08 | 08/04/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-220-08 | 18/11/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-152-08 | 12/08/2013 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-152-08 | 12/08/2013 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-15-08 | 23/01/2013 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-15-08 | 23/01/2013 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2011-237-08 | 16/12/2011 | Barcelona | Descargar |