SOLVASA SL

Activa

AVENIDA MAR, S/N
 Santa Susanna, Barcelona  (08398)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 27/02/2018

GESTIHOTELS ALEGRIA SL

Apoderado solidario
Cese: 08/04/2015

VALLS LLORET JOSE DOMINGO

Administrador solidario
Cese: 08/04/2015

SERRANO GONZALEZ RAFAEL

Administrador solidario
Nombramiento: 08/04/2015

SERRANO GONZALEZ RAFAEL

Administrador solidario
Nombramiento: 08/04/2015

PASCUAL COMAS JOAN

Administrador solidario
Cese: 18/11/2014

VALLS LLORET JOSE DOMINGO

Administrador solidario
Cese: 18/11/2014

SERRANO GONZALEZ RAFAEL

Administrador solidario
Nombramiento: 18/11/2014

VALLS LLORET JOSE DOMINGO

Administrador solidario
Nombramiento: 18/11/2014

SERRANO GONZALEZ RAFAEL

Administrador solidario
Cese: 23/01/2013

SEGURA OLIVARES CONSUELO

Consejero
Cese: 23/01/2013

RECIO JURADO DOLORES

Consejero
Cese: 23/01/2013

RECIO JURADO DOLORES

Secretario
Cese: 23/01/2013

RECIO JURADO ISIDORO

Consejero
Cese: 23/01/2013

RECIO JURADO ISIDORO

Presidente
Nombramiento: 23/01/2013

VALLS LLORET JOSE DOMINGO

Administrador solidario
Nombramiento: 23/01/2013

SERRANO GONZALEZ RAFAEL

Administrador solidario
Nombramiento: 23/01/2013

FERGUS HOTELS SL

Apoderado
Cese: 16/12/2011

RECIO GOMEZ JUAN

Consejero
Cese: 16/12/2011

RECIO GOMEZ JUAN

Presidente
Cese: 16/12/2011

RECIO JURADO DOLORES

Consejero
Cese: 16/12/2011

RECIO JURADO DOLORES

Secretario
Cese: 16/12/2011

RECIO JURADO ISIDORO

Consejero
Cese: 16/12/2011

SEGURA OLIVARES CONSUELO

Consejero
Nombramiento: 16/12/2011

SEGURA OLIVARES CONSUELO

Consejero
Nombramiento: 16/12/2011

RECIO JURADO DOLORES

Consejero
Nombramiento: 16/12/2011

RECIO JURADO DOLORES

Secretario
Nombramiento: 16/12/2011

RECIO JURADO ISIDORO

Consejero
Nombramiento: 16/12/2011

RECIO JURADO ISIDORO

Presidente

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SOLVASA SL

12/02/2019 Detalles del anuncio (63241) Datos registrales: T 22199 , F 47, S 8, H B 113691, I/A 27 ( 4.02.19).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 15.540,00 Euros. Resultante Suscrito: 341.418,00 Euros.

27/02/2018 Detalles del anuncio (92513) Datos registrales: T 22199 , F 46, S 8, H B 113691, I/A 26 (16.02.18).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: GESTIHOTELS ALEGRIA SL.

25/01/2018 Detalles del anuncio (38493) Datos registrales: T 22199 , F 46, S 8, H B 113691, I/A 25 (16.01.18).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 46.374,00 Euros. Resultante Suscrito: 356.958,00 Euros.

08/04/2015 Detalles del anuncio (145510) Datos registrales: T 22199 , F 46, S 8, H B 113691, I/A 24 (30.03.15).

  • Revocaciones

    ADM.SOLIDAR.: VALLS LLORET JOSE DOMINGO;SERRANO GONZALEZ RAFAEL.

  • Nombramientos

    ADM.SOLIDAR.: SERRANO GONZALEZ RAFAEL;PASCUAL COMAS JOAN.

18/11/2014 Detalles del anuncio (467192) Datos registrales: T 7424 , F 175, S 8, H B 113691, I/A 23 (10.11.14).

  • Transformación de Sociedad

    Denominación y forma adoptada: SOLVASA SL.

  • Revocaciones

    ADM.SOLIDAR.: VALLS LLORET JOSE DOMINGO;SERRANO GONZALEZ RAFAEL.

  • Nombramientos

    ADM.SOLIDAR.: VALLS LLORET JOSE DOMINGO;SERRANO GONZALEZ RAFAEL.

12/08/2013 Detalles del anuncio (358544) Datos registrales: T 7424 , F 174, S 8, H B 113691, I/A 21 ( 1.08.13).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 445,33 Euros. Resultante Suscrito: 264.000,00 Euros.

12/08/2013 Detalles del anuncio (358545) Datos registrales: T 7424 , F 174, S 8, H B 113691, I/A 22 ( 1.08.13).

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 46.584,00 Euros. Desembolsado: 46.584,00 Euros. Resultante Suscrito: 310.584,00 Euros. Resultante Desembolsado: 310.584,00 Euros.

23/01/2013 Detalles del anuncio (32877) Datos registrales: T 7424 , F 173, S 8, H B 113691, I/A 19 (15.01.13).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: SEGURA OLIVARES CONSUELO;RECIO JURADO DOLORES. SECRETARIO: RECIO JURADO DOLORES. CONSEJERO: RECIO JURADO ISIDORO. PRESIDENTE: RECIO JURADO ISIDORO.

  • Nombramientos

    ADM.SOLIDAR.: VALLS LLORET JOSE DOMINGO;SERRANO GONZALEZ RAFAEL.

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION ARTS.13,23,PRIMER PARRAFO DEL ART.26,27 Y SUPRESION ART.28:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.

23/01/2013 Detalles del anuncio (32866) Datos registrales: T 7424 , F 174, S 8, H B 113691, I/A 20 (15.01.13).

  • Nombramientos

    APODERADO: FERGUS HOTELS SL.

16/12/2011 Detalles del anuncio (499623) Datos registrales: T 7424 , F 173, S 8, H B 113691, I/A 18 ( 5.12.11).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: RECIO GOMEZ JUAN. PRESIDENTE: RECIO GOMEZ JUAN. CONSEJERO: RECIO JURADO DOLORES. SECRETARIO: RECIO JURADO DOLORES. CONSEJERO: RECIO JURADO ISIDORO;SEGURA OLIVARES CONSUELO.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: SEGURA OLIVARES CONSUELO;RECIO JURADO DOLORES. SECRETARIO: RECIO JURADO DOLORES. CONSEJERO: RECIO JURADO ISIDORO. PRESIDENTE: RECIO JURADO ISIDORO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 13

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2019-29-08 12/02/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-41-08 27/02/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-18-08 25/01/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-65-08 08/04/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-220-08 18/11/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-152-08 12/08/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-152-08 12/08/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-15-08 23/01/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-15-08 23/01/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-237-08 16/12/2011 Barcelona Descargar