SOL EDIFICAT PONENT SL

Activa

CL FONT DE LAMETLLO Num.11 (VILAFRANCA DEL PENEDES).
 Vilafranca del Penedès, Barcelona  (08720)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 22/01/2021

GRUPO GISPERT ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP

Administrador concurs.
Nombramiento: 22/01/2021

GARCIA GARCIA JOSEP

Representante administrador concurs.
Cese: 04/12/2012

TERMES CANALS ISIDRE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 04/12/2012

CASTELLS PLA RICARD

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 15/06/2012

BOLIART RIERA ANGEL

Apoderado
Cese: 15/06/2012

TERMES CANALS ISIDRE

Apoderado
Cese: 15/06/2012

DENIA FLORES JOSE

Apoderado
Cese: 15/06/2012

BOLIART RIERA ANGEL

Apoderado
Cese: 15/06/2012

OLIVELLA MATA ALBERTO

Apoderado
Cese: 15/06/2012

TERMES CANALS ISIDRE

Apoderado
Cese: 15/06/2012

COMELLAS FUSTE RAMON

Consejero
Cese: 15/06/2012

PONS SIMON RAMON

Consejero
Cese: 15/06/2012

VOLUM EDIFICAT SL

Consejero
Cese: 15/06/2012

VOLUM EDIFICAT SL

Presidente
Cese: 15/06/2012

MUNYOS ESCUDE FRANCESC XAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 15/06/2012

MUNYOS ESCUDE FRANCESC XAVIER

Apoderado
Cese: 15/06/2012

REALES PASTOR BENITO

Apoderado
Cese: 15/06/2012

SAUTEK 2001 SL

Consejero
Cese: 15/06/2012

PONS SIMON RAMON

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 15/06/2012

REVALUA INVERSIONS SL

Consejero
Cese: 15/06/2012

TERMES CANALS ISIDRE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 15/06/2012

TERMES CANALS ISIDRE

Consejero
Cese: 15/06/2012

MARTINEZ MARTOS JOSE MARIA

Consejero
Cese: 15/06/2012

GUERRA RAYA JOSE MANUEL

Consejero
Cese: 15/06/2012

MARISCAL GARCIA MARIA VICTORIA

Secretario no consejero
Nombramiento: 15/06/2012

REVALUA INVERSIONS SL

Administrador conjunto
Nombramiento: 15/06/2012

TERMES CANALS ISIDRE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 15/06/2012

MAPES PROMOCIONS INMOBILIARIES PER LA NOVA LLAR SL

Administrador conjunto
Nombramiento: 15/06/2012

PEREZ AGUILAR JOSE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 31/05/2012

PENEDESCEP SA

Consejero
Cese: 31/05/2012

PENEDESCEP SA

Vicepresidente
Cese: 31/05/2012

CAELLAS FERNANDEZ JUAN

Consejero
Cese: 31/05/2012

SAUTEK 2001 SL

Consejero
Cese: 31/05/2012

OLIVELLA MATA ALBERTO

Consejero
Cese: 31/05/2012

TERMES CANALS ISIDRE

Consejero
Cese: 31/05/2012

RECASENS PARES JAIME

Secretario no consejero
Cese: 31/05/2012

TROYANO MOLINA MANUEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 31/05/2012

PONS SIMON RAMON

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 31/05/2012

SAUTEK 2001 SL

Consejero
Nombramiento: 31/05/2012

PONS SIMON RAMON

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 31/05/2012

REVALUA INVERSIONS SL

Consejero
Nombramiento: 31/05/2012

TERMES CANALS ISIDRE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 31/05/2012

TERMES CANALS ISIDRE

Consejero
Nombramiento: 31/05/2012

MARTINEZ MARTOS JOSE MARIA

Consejero
Nombramiento: 31/05/2012

GUERRA RAYA JOSE MANUEL

Consejero
Nombramiento: 31/05/2012

MARISCAL GARCIA MARIA VICTORIA

Secretario no consejero
Cese: 09/01/2012

DENIA FLORES JOSE

Apoderado
Cese: 09/01/2012

OLIVELLA MATA ALBERTO

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2012

MUNYOS ESCUDE FRANCESC XAVIER

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2012

REALES PASTOR BENITO

Apoderado
Cese: 09/01/2012

BOLIART RIERA ANGEL

Apoderado
Cese: 09/01/2012

TERMES CANALS ISIDRE

Apoderado
Cese: 09/01/2012

DENIA FLORES JOSE

Consejero
Cese: 09/01/2012

DENIA FLORES JOSE

Presidente
Cese: 09/01/2012

DENIA FLORES JOSE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 09/01/2012

PONS SIMON RAMON

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 09/01/2012

VOLUM EDIFICAT SL

Consejero
Nombramiento: 09/01/2012

VOLUM EDIFICAT SL

Presidente
Nombramiento: 09/01/2012

MUNYOS ESCUDE FRANCESC XAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 12/07/2010

DELOITTE SL

Auditor de cuentas
Cese: 16/02/2009

BOLIART RIERA ANGEL

Consejero
Cese: 16/02/2009

TERRASSA ACTIVA PROMOCIONS INMOBILIARIES SL

Consejero
Cese: 16/02/2009

BOLIART RIERA ANGEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 16/02/2009

COMELLAS FUSTE RAMON

Consejero
Nombramiento: 16/02/2009

PONS SIMON RAMON

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SOL EDIFICAT PONENT SL

22/01/2021 Detalles del anuncio (30548) Datos registrales: T 43198 , F 14, S 8, H B 339282, I/A 15 (15.01.21).

  • Nombramientos

    ADM.CONCURS.: GRUPO GISPERT ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP. REP.ADM.CONC: GARCIA GARCIA JOSEP.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 24012020, AUTO FIRME DE FECHA 24/01/2020, DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD.

04/12/2012 Detalles del anuncio (498811) Datos registrales: T 43198 , F 13, S 8, H B 339282, I/A 14 (23.11.12).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: TERMES CANALS ISIDRE.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: CASTELLS PLA RICARD.

15/06/2012 Detalles del anuncio (252862) Datos registrales: T 38942 , F 195, S 8, H B 339282, I/A 13 ( 5.06.12).

  • Revocaciones

    APODERADO: BOLIART RIERA ANGEL;TERMES CANALS ISIDRE;DENIA FLORES JOSE;BOLIART RIERA ANGEL;OLIVELLA MATA ALBERTO;TERMES CANALS ISIDRE. CONSEJERO: COMELLAS FUSTE RAMON;PONS SIMON RAMON;VOLUM EDIFICAT SL. PRESIDENTE: VOLUM EDIFICAT SL. REPR.143 RRM: MUNYOS ESCUDE FRANCESC XAVIER. APODERADO: MUNYOS ESCUDE FRANCESC XAVIER;REALES PASTOR BENITO. CONSEJERO: SAUTEK 2001 SL. REPR.143 RRM: PONS SIMON RAMON. CONSEJERO: REVALUA INVERSIONS SL. REPR.143 RRM: TERMES CANALS ISIDRE. CONSEJERO: TERMES CANALS ISIDRE;MARTINEZ MARTOS JOSE MARIA;GUERRA RAYA JOSE MANUEL. SECR.NO CONS: MARISCAL GARCIA MARIA VICTORIA.

  • Nombramientos

    ADM.CONJUNTO: REVALUA INVERSIONS SL. REPR.143 RRM: TERMES CANALS ISIDRE. ADM.CONJUNTO: MAPES PROMOCIONS INMOBILIARIES PER LA NOVA LLAR SL. REPR.143 RRM: PEREZ AGUILAR JOSE.

  • Modificaciones Estatutarias

    ARTS.8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22 Y 25:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.

  • Cambio de domicilio social

    CL FONT DE LAMETLLO Num.11 (VILAFRANCA DEL PENEDES).

31/05/2012 Detalles del anuncio (230565) Datos registrales: T 38942 , F 194, S 8, H B 339282, I/A 12 (22.05.12).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: PENEDESCEP SA. VICEPRESIDEN: PENEDESCEP SA. CONSEJERO: CAELLAS FERNANDEZ JUAN;SAUTEK 2001 SL;OLIVELLA MATA ALBERTO;TERMES CANALS ISIDRESECR.NO CONS: RECASENS PARES JAIME. REPR.143 RRM: TROYANO MOLINA MANUEL;PONS SIMON RAMON.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: SAUTEK 2001 SL. REPR.143 RRM: PONS SIMON RAMON. CONSEJERO: REVALUA INVERSIONS SL. REPR.143 RRM: TERMES CANALS ISIDRE. CONSEJERO: TERMES CANALS ISIDRE;MARTINEZ MARTOS JOSE MARIA;GUERRA RAYA JOSE MANUEL. SECR.NO CONS: MARISCAL GARCIA MARIA VICTORIA.

09/01/2012 Detalles del anuncio (8487) Datos registrales: T 38942 , F 192, S 8, H B 339282, I/A 11 (27.12.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: DENIA FLORES JOSE;OLIVELLA MATA ALBERTO.

  • Nombramientos

    APODERADO: MUNYOS ESCUDE FRANCESC XAVIER;REALES PASTOR BENITO.

  • Modificación de poderes

    APODERADO: BOLIART RIERA ANGEL;TERMES CANALS ISIDRE.

09/01/2012 Detalles del anuncio (8757) Datos registrales: T 38942 , F 192, S 8, H B 339282, I/A 10 (27.12.11).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: DENIA FLORES JOSE. PRESIDENTE: DENIA FLORES JOSE. REPR.143 RRM: DENIA FLORES JOSE.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: PONS SIMON RAMON. CONSEJERO: VOLUM EDIFICAT SL. PRESIDENTE: VOLUM EDIFICAT SL. REPR.143 RRM: MUNYOS ESCUDE FRANCESC XAVIER.

18/02/2011 Detalles del anuncio (82058)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Enero de 2011) Año: 2009

12/07/2010 Detalles del anuncio (273537) Datos registrales: T 38942 , F 191, S 8, H B 339282, I/A 9 (30.06.10).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL.

27/01/2010 Detalles del anuncio (65716)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Diciembre de 2009) Año: 2008

28/07/2009 Detalles del anuncio (332891) Datos registrales: T 38942 , F 191, S 8, H B 339282, I/A 8 (15.07.09).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.800.000,00 Euros.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2021-14-08 22/01/2021 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-232-08 04/12/2012 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-113-08 15/06/2012 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-102-08 31/05/2012 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-5-08 09/01/2012 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-5-08 09/01/2012 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-34-08 18/02/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-131-08 12/07/2010 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-17-08 27/01/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-141-08 28/07/2009 Barcelona Descargar