SERCOM ACTIVOS INMOBILIARIOS SL

Activa

C/ SANTA ENGRACIA 72 - 1.C (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 04/08/2023

ZAPATERO HERRERO FRANCISCO-ROBERTO

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/05/2023

ASE AUDIT CONSULTANTS SLP

Auditor
Cese: 20/01/2022

ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO

Consejero
Cese: 20/01/2022

ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO

Presidente
Cese: 20/01/2022

CANOVAS CAMARA FRANCISCO

Consejero
Cese: 20/01/2022

CANOVAS CAMARA FRANCISCO

Secretario
Cese: 20/01/2022

DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS

Consejero
Nombramiento: 20/01/2022

CANOVAS RIVAS SERGIO

Administrador único
Nombramiento: 13/12/2016

ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 13/12/2016

CANOVAS CAMARA FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 13/12/2016

DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS

Apoderado
Nombramiento: 31/12/2014

ASE AUDITORES SLP

Auditor
Nombramiento: 30/05/2014

ABANTOS AUDITORES Y ASESORES SL

Auditor
Cese: 10/10/2013

DEL PECHO GOMEZ BASILIO

Consejero
Cese: 10/10/2013

ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO

Consejero delegado solidario
Cese: 10/10/2013

CANOVAS CAMARA FRANCISCO

Consejero delegado solidario
Cese: 10/10/2013

DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 10/10/2013

GIL VITORES ROBERTO

Apoderado
Cese: 16/03/2012

DEL PECHO GOMEZ BASILIO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 17/01/2012

ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 17/01/2012

CANOVAS CAMARA FRANCISCO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 17/01/2012

DEL PECHO GOMEZ BASILIO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 17/01/2012

DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS

Consejero delegado solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SERCOM ACTIVOS INMOBILIARIOS SL

13/05/2024 Detalles del anuncio (218366) Datos registrales: T 20926 , F 132, S 8, H M 371051, I/A 14 (30.04.24).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 450.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros.

04/08/2023 Detalles del anuncio (353385) Datos registrales: T 20926 , F 131, S 8, H M 371051, I/A 13 (28.07.23).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: ZAPATERO HERRERO FRANCISCO-ROBERTO.

09/05/2023 Detalles del anuncio (211797) Datos registrales: T 20926 , F 131, S 8, H M 371051, I/A 12 (28.04.23).

  • Nombramientos

    Auditor: ASE AUDIT CONSULTANTS SLP.

20/01/2022 Detalles del anuncio (26042) Datos registrales: T 20926 , F 131, S 8, H M 371051, I/A 11 (13.01.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO. Presidente: ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO. Consejero: CANOVAS CAMARA FRANCISCO. Secretario: CANOVAS CAMARA FRANCISCO. Consejero: DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: CANOVAS RIVAS SERGIO.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

02/06/2021 Detalles del anuncio (266413) Datos registrales: T 20926 , F 131, S 8, H M 371051, I/A 10 (26.05.21).

  • Cambio de domicilio social

    C/ SANTA ENGRACIA 72 - 1.C (MADRID).

13/12/2016 Detalles del anuncio (504616) Datos registrales: T 20926 , F 130, S 8, H M 371051, I/A 9 ( 1.12.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO;CANOVAS CAMARA FRANCISCO;DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS.

31/12/2014 Detalles del anuncio (534876) Datos registrales: T 20926 , F 130, S 8, H M 371051, I/A 8 (22.12.14).

  • Nombramientos

    Auditor: ASE AUDITORES SLP.

30/05/2014 Detalles del anuncio (228625) Datos registrales: T 20926 , F 129, S 8, H M 371051, I/A 7 (22.05.14).

  • Nombramientos

    Auditor: ABANTOS AUDITORES Y ASESORES SL.

10/10/2013 Detalles del anuncio (434497) Datos registrales: T 20926 , F 128, S 8, H M 371051, I/A 6 ( 2.10.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DEL PECHO GOMEZ BASILIO. Cons.Del.Sol: ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO;CANOVAS CAMARA FRANCISCO;DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS.

  • Nombramientos

    Apoderado: GIL VITORES ROBERTO.

16/03/2012 Detalles del anuncio (127194) Datos registrales: T 20926 , F 128, S 8, H M 371051, I/A 5 ( 6.03.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Cons.Del.Sol: DEL PECHO GOMEZ BASILIO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 15

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2024-91-28 13/05/2024 Madrid Descargar
BORME-A-2023-148-28 04/08/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-86-28 09/05/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2022-13-28 20/01/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-103-28 02/06/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2016-235-28 13/12/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2014-249-28 31/12/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-101-28 30/05/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-194-28 10/10/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-54-28 16/03/2012 Madrid Descargar