SERCOM ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
Fecha
|
Nombre
|
|
---|---|---|
Nombramiento: 04/08/2023 | ZAPATERO HERRERO FRANCISCO-ROBERTO |
Apoderado solidario |
Nombramiento: 09/05/2023 | ASE AUDIT CONSULTANTS SLP |
Auditor |
Cese: 20/01/2022 | ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO |
Consejero |
Cese: 20/01/2022 | ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO |
Presidente |
Cese: 20/01/2022 | CANOVAS CAMARA FRANCISCO |
Consejero |
Cese: 20/01/2022 | CANOVAS CAMARA FRANCISCO |
Secretario |
Cese: 20/01/2022 | DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS |
Consejero |
Nombramiento: 20/01/2022 | CANOVAS RIVAS SERGIO |
Administrador único |
Nombramiento: 13/12/2016 | ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO |
Apoderado |
Nombramiento: 13/12/2016 | CANOVAS CAMARA FRANCISCO |
Apoderado |
Nombramiento: 13/12/2016 | DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS |
Apoderado |
Nombramiento: 31/12/2014 | ASE AUDITORES SLP |
Auditor |
Nombramiento: 30/05/2014 | ABANTOS AUDITORES Y ASESORES SL |
Auditor |
Cese: 10/10/2013 | DEL PECHO GOMEZ BASILIO |
Consejero |
Cese: 10/10/2013 | ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO |
Consejero delegado solidario |
Cese: 10/10/2013 | CANOVAS CAMARA FRANCISCO |
Consejero delegado solidario |
Cese: 10/10/2013 | DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS |
Consejero delegado solidario |
Nombramiento: 10/10/2013 | GIL VITORES ROBERTO |
Apoderado |
Cese: 16/03/2012 | DEL PECHO GOMEZ BASILIO |
Consejero delegado solidario |
Nombramiento: 17/01/2012 | ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO |
Consejero delegado solidario |
Nombramiento: 17/01/2012 | CANOVAS CAMARA FRANCISCO |
Consejero delegado solidario |
Nombramiento: 17/01/2012 | DEL PECHO GOMEZ BASILIO |
Consejero delegado solidario |
Nombramiento: 17/01/2012 | DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS |
Consejero delegado solidario |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SERCOM ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
13/05/2024 Detalles del anuncio (218366) Datos registrales: T 20926 , F 132, S 8, H M 371051, I/A 14 (30.04.24).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 450.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros.
04/08/2023 Detalles del anuncio (353385) Datos registrales: T 20926 , F 131, S 8, H M 371051, I/A 13 (28.07.23).
- Nombramientos
Apo.Sol.: ZAPATERO HERRERO FRANCISCO-ROBERTO.
09/05/2023 Detalles del anuncio (211797) Datos registrales: T 20926 , F 131, S 8, H M 371051, I/A 12 (28.04.23).
- Nombramientos
Auditor: ASE AUDIT CONSULTANTS SLP.
20/01/2022 Detalles del anuncio (26042) Datos registrales: T 20926 , F 131, S 8, H M 371051, I/A 11 (13.01.22).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO. Presidente: ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO. Consejero: CANOVAS CAMARA FRANCISCO. Secretario: CANOVAS CAMARA FRANCISCO. Consejero: DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS.
- Nombramientos
Adm. Unico: CANOVAS RIVAS SERGIO.
- Otros Conceptos
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.
02/06/2021 Detalles del anuncio (266413) Datos registrales: T 20926 , F 131, S 8, H M 371051, I/A 10 (26.05.21).
- Cambio de domicilio social
C/ SANTA ENGRACIA 72 - 1.C (MADRID).
13/12/2016 Detalles del anuncio (504616) Datos registrales: T 20926 , F 130, S 8, H M 371051, I/A 9 ( 1.12.16).
- Nombramientos
Apoderado: ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO;CANOVAS CAMARA FRANCISCO;DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS.
31/12/2014 Detalles del anuncio (534876) Datos registrales: T 20926 , F 130, S 8, H M 371051, I/A 8 (22.12.14).
- Nombramientos
Auditor: ASE AUDITORES SLP.
30/05/2014 Detalles del anuncio (228625) Datos registrales: T 20926 , F 129, S 8, H M 371051, I/A 7 (22.05.14).
- Nombramientos
Auditor: ABANTOS AUDITORES Y ASESORES SL.
10/10/2013 Detalles del anuncio (434497) Datos registrales: T 20926 , F 128, S 8, H M 371051, I/A 6 ( 2.10.13).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: DEL PECHO GOMEZ BASILIO. Cons.Del.Sol: ZAPATERO DEL PECHO FRANCISCO;CANOVAS CAMARA FRANCISCO;DE MIGUEL LLORENTE JOSE LUIS.
- Nombramientos
Apoderado: GIL VITORES ROBERTO.
16/03/2012 Detalles del anuncio (127194) Datos registrales: T 20926 , F 128, S 8, H M 371051, I/A 5 ( 6.03.12).
- Ceses/Dimisiones
Cons.Del.Sol: DEL PECHO GOMEZ BASILIO.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 15
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
---|---|---|---|
BORME-A-2024-91-28 | 13/05/2024 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2023-148-28 | 04/08/2023 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2023-86-28 | 09/05/2023 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2022-13-28 | 20/01/2022 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2021-103-28 | 02/06/2021 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2016-235-28 | 13/12/2016 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2014-249-28 | 31/12/2014 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2014-101-28 | 30/05/2014 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2013-194-28 | 10/10/2013 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2012-54-28 | 16/03/2012 | Madrid | Descargar |