REEIF HOLDING PORTFOLIO SL

Cambio de denominación social

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 28/10/2011

SANCHEZ APARICIO LUIS

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 28/10/2011

CORDERO IRLES FRANCISCO

Vicesecretario no consejero
Cese: 02/07/2010

SAMPER GARCINUÑO ANGEL

Apoderado
Cese: 04/05/2010

VERMAAS JAN

Apoderado
Cese: 04/05/2010

MARTIN BORREGON CASTAÑEDA JOSE ANTONIO

Apoderado
Cese: 04/05/2010

MUÑOZ TERRADEZ CARLOS

Apoderado
Cese: 04/05/2010

GIL PEREZ CARRO ANTONIO

Apoderado
Cese: 04/05/2010

SANCHEZ APARICIO LUIS

Apoderado
Cese: 04/05/2010

FERNANDEZ POZUELO FRANCISCO DE ASIS

Apoderado
Cese: 04/05/2010

SAMPER GARCINUÑO ANGEL

Apoderado
Cese: 04/05/2010

CHOITHRAMANI BECERRA PABLO

Apoderado
Cese: 04/05/2010

FERNANDEZ BLANCO PILAR

Apoderado
Cese: 04/05/2010

ATIENZA JIMENEZ ANA

Apoderado
Cese: 04/05/2010

ARROYO MIRA JUAN JOSE

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

VERMAAS JAN

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

MARTIN BORREGON CASTAÑEDA JOSE ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

AMARO SANCHEZ ADOLFO

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

GIL PEREZ CARRO ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

MUÑOZ TERRADEZ CARLOS-JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

SAMPER GARCINUÑO ANGEL

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

SANCHEZ APARICIO LUIS

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

CORDERO IRLES FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

RUMAYOR FERNANDEZ ALEJANDRO

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

FERNANDEZ BLANCO PILAR

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

ATIENZA JIMENEZ ANA

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

ROMERA JARABA DAVID

Apoderado
Cese: 28/05/2009

VERMAAS JAN

Apoderado
Cese: 28/05/2009

MARTIN-BORREGON CASTAÑEDA JOSE ANTONIO

Apoderado
Cese: 28/05/2009

MAES DOMINIQUE MICHEL

Apoderado
Cese: 28/05/2009

GIL PEREZ CARRO ANTONIO

Apoderado
Cese: 28/05/2009

SANCHEZ APARICIO LUIS

Apoderado
Cese: 28/05/2009

PAÑOS CASTELEIRO DELFIN

Apoderado
Cese: 28/05/2009

FERNANDEZ POZUELO FRANCISCO DE ASIS

Apoderado
Cese: 28/05/2009

CABRERA REBATO SUSANA

Apoderado
Cese: 28/05/2009

CHOITHRAMANI BECERRA PABLO

Apoderado
Cese: 28/05/2009

ASENSIO GONZALEZ AGUSTIN

Apoderado
Cese: 28/05/2009

CASTILLO NAVARRO REVERTER PALOMA

Apoderado
Cese: 28/05/2009

ATIENZA JIMENEZ ANA ISABEL

Apoderado
Cese: 28/05/2009

ARROYO MIRA JUAN JOSE

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

MUÑOZ TERRADEZ CARLOS

Secretario
Nombramiento: 28/05/2009

VERMAAS JAN

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

MARTIN BORREGON CASTAÑEDA JOSE ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

MUÑOZ TERRADEZ CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

GIL PEREZ CARRO ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

SANCHEZ APARICIO LUIS

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

FERNANDEZ POZUELO FRANCISCO DE ASIS

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

SAMPER GARCINUÑO ANGEL

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

CHOITHRAMANI BECERRA PABLO

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

FERNANDEZ BLANCO PILAR

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

ATIENZA JIMENEZ ANA

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2009

ARROYO MIRA JUAN JOSE

Apoderado
Cese: 26/05/2009

MAES DOMINIQUE MICHEL

Consejero
Cese: 26/05/2009

MAES DOMINIQUE MICHEL

Secretario
Nombramiento: 26/05/2009

MUÑOZ TERRADEZ CARLOS

Consejero
Nombramiento: 26/05/2009

FERNANDEZ BLANCO MARIA PILAR

Consejero suplente

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por REEIF HOLDING PORTFOLIO SL

30/11/2011 Detalles del anuncio (479674) Datos registrales: T 24399 , F 215, S 8, H M 430577, I/A 16 (21.11.11).

  • Cambio de denominación social

    EIF HOLDING PORTFOLIO SL.

28/10/2011 Detalles del anuncio (429772) Datos registrales: T 24399 , F 214, S 8, H M 430577, I/A 15 (17.10.11).

  • Ceses/Dimisiones

    VsecrNoConsj: SANCHEZ APARICIO LUIS.

  • Nombramientos

    VsecrNoConsj: CORDERO IRLES FRANCISCO.

08/06/2011 Detalles del anuncio (244857) Datos registrales: T 24399 , F 213, S 8, H M 430577, I/A 14 (27.05.11).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 135,00 Euros. Resultante Suscrito: 467.885,00 Euros.

27/10/2010 Detalles del anuncio (397247) Datos registrales: T 24399 , F 213, S 8, H M 430577, I/A 13 (14.10.10).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 22.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 467.750,00 Euros.

01/10/2010 Detalles del anuncio (728058)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2010) Año: 2009

02/07/2010 Detalles del anuncio (264443) Datos registrales: T 24399 , F 213, S 8, H M 430577, I/A 12 (22.06.10).

  • Revocaciones

    Apoderado: SAMPER GARCINUÑO ANGEL.

04/05/2010 Detalles del anuncio (179870) Datos registrales: T 24399 , F 211, S 8, H M 430577, I/A 11 (22.04.10).

  • Revocaciones

    Apoderado: VERMAAS JAN;MARTIN BORREGON CASTAÑEDA JOSE ANTONIO;MUÑOZ TERRADEZ CARLOS;GIL PEREZ CARRO ANTONIO;SANCHEZ APARICIO LUIS;FERNANDEZ POZUELO FRANCISCO DE ASIS;SAMPER GARCINUÑO ANGEL;CHOITHRAMANI BECERRA PABLO;FERNANDEZ BLANCO PILAR;ATIENZA JIMENEZ ANA;ARROYO MIRA JUAN JOSE.

  • Nombramientos

    Apoderado: VERMAAS JAN;MARTIN BORREGON CASTAÑEDA JOSE ANTONIO;AMARO SANCHEZ ADOLFO;GIL PEREZ CARRO ANTONIO;MUÑOZ TERRADEZ CARLOS-JAVIER;SAMPER GARCINUÑO ANGEL;SANCHEZ APARICIO LUIS;CORDERO IRLES FRANCISCO;RUMAYOR FERNANDEZ ALEJANDRO;FERNANDEZ BLANCO PILAR;ATIENZA JIMENEZ ANA;ROMERA JARABA DAVID.

15/12/2009 Detalles del anuncio (1014159)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Noviembre de 2009) Año: 2008

28/05/2009 Detalles del anuncio (244291) Datos registrales: T 24399 , F 208, S 8, H M 430577, I/A 10 (18.05.09).

  • Revocaciones

    Apoderado: VERMAAS JAN;MARTIN-BORREGON CASTAÑEDA JOSE ANTONIO;MAES DOMINIQUE MICHEL;GIL PEREZ CARRO ANTONIO;SANCHEZ APARICIO LUIS;PAÑOS CASTELEIRO DELFIN;FERNANDEZ POZUELO FRANCISCO DE ASIS;CABRERA REBATO SUSANA;CHOITHRAMANI BECERRA PABLO;ASENSIO GONZALEZ AGUSTIN;CASTILLO NAVARRO REVERTER PALOMA;ATIENZA JIMENEZ ANA ISABEL;ARROYO MIRA JUAN JOSE.

  • Nombramientos

    Secretario: MUÑOZ TERRADEZ CARLOS. Apoderado: VERMAAS JAN;MARTIN BORREGON CASTAÑEDA JOSE ANTONIO;MUÑOZ TERRADEZ CARLOS;GIL PEREZ CARRO ANTONIO;SANCHEZ APARICIO LUIS;FERNANDEZ POZUELO FRANCISCO DE ASIS;SAMPER GARCINUÑO ANGEL;CHOITHRAMANI BECERRA PABLO;FERNANDEZ BLANCO PILAR;ATIENZA JIMENEZ ANA;ARROYO MIRA JUAN JOSE.

26/05/2009 Detalles del anuncio (239040) Datos registrales: T 24399 , F 208, S 8, H M 430577, I/A 9 (14.05.09).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MAES DOMINIQUE MICHEL. Secretario: MAES DOMINIQUE MICHEL.

  • Nombramientos

    Consejero: MUÑOZ TERRADEZ CARLOS. ConsejSuplen: FERNANDEZ BLANCO MARIA PILAR.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 10

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2011-227-28 30/11/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-206-28 28/10/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-109-28 08/06/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2010-207-28 27/10/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2010-190-28 01/10/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-125-28 02/07/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-83-28 04/05/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2009-238-28 15/12/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-99-28 28/05/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-97-28 26/05/2009 Madrid Descargar