PROTON LASER APPLICATIONS SL

Extinta

CALLE NORBERTO CUESTA DUTARI, 39 - PISO 4 D
Salamanca  (37007)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 25/10/2017

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Presidente
Nombramiento: 25/10/2017

PEREZ AZPILLAGA JAVIER

Presidente
Nombramiento: 26/06/2017

CALLEJA PINILLA CARMEN-MARIA

Auditor
Cese: 12/04/2012

ENGIND SL

Consejero
Cese: 12/04/2012

ENGIND SL

Secretario
Cese: 12/04/2012

ENGIND SL

Consejero delegado
Cese: 12/04/2012

VOCES SANCHEZ FELIPE

Presidente
Nombramiento: 12/04/2012

PRODEL 2011 SL

Consejero
Nombramiento: 12/04/2012

PRODEL 2011 SL

Secretario
Nombramiento: 12/04/2012

GALAN VALIENTE MIGUEL

Consejero
Nombramiento: 12/04/2012

PEREZ AZPILLAGA JAVIER

Consejero
Nombramiento: 12/04/2012

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Presidente
Nombramiento: 12/04/2012

PRODEL 2011 SL

Consejero delegado
Nombramiento: 12/04/2012

VOCES SANCHEZ FELIPE

Vicepresidente
Nombramiento: 12/04/2012

VOCES SANCHEZ FELIPE

Apoderado
Cese: 27/12/2011

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Presidente
Cese: 27/12/2011

SAUS MAS VICENTE

Consejero
Cese: 27/12/2011

SAUS MAS VICENTE

Secretario
Cese: 27/12/2011

VOCES SANCHEZ FELIPE

Vicepresidente
Cese: 27/12/2011

SAUS MAS VICENTE

Consejero delegado
Nombramiento: 27/12/2011

ENGIND SL

Consejero
Nombramiento: 27/12/2011

ENGIND SL

Secretario
Nombramiento: 27/12/2011

ENGIND SL

Consejero delegado
Nombramiento: 27/12/2011

VOCES SANCHEZ FELIPE

Presidente
Cese: 27/12/2011

VOCES SANCHEZ FELIPE

Apoderado
Cese: 09/06/2011

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Administrador solidario
Cese: 09/06/2011

VOCES SANCHEZ FELIPE

Administrador solidario
Nombramiento: 09/06/2011

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Consejero
Nombramiento: 09/06/2011

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Presidente
Nombramiento: 09/06/2011

SAUS MAS VICENTE

Consejero
Nombramiento: 09/06/2011

SAUS MAS VICENTE

Secretario
Nombramiento: 09/06/2011

VOCES SANCHEZ FELIPE

Consejero
Nombramiento: 09/06/2011

VOCES SANCHEZ FELIPE

Vicepresidente
Nombramiento: 09/06/2011

SAUS MAS VICENTE

Consejero delegado
Cese: 09/06/2011

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Consejero
Cese: 09/06/2011

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Presidente
Cese: 09/06/2011

VOCES SANCHEZ FELIPE

Consejero
Cese: 09/06/2011

VOCES SANCHEZ FELIPE

Secretario
Cese: 09/06/2011

IBERDIAGNOSIS SL

Consejero
Cese: 09/06/2011

IBERDIAGNOSIS SL

Consejero delegado
Nombramiento: 09/06/2011

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Administrador solidario
Nombramiento: 09/06/2011

VOCES SANCHEZ FELIPE

Administrador solidario
Nombramiento: 11/04/2011

VOCES SANCHEZ FELIPE

Apoderado
Nombramiento: 10/11/2010

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Consejero
Nombramiento: 10/11/2010

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA

Presidente
Nombramiento: 10/11/2010

VOCES SANCHEZ FELIPE

Consejero
Nombramiento: 10/11/2010

VOCES SANCHEZ FELIPE

Secretario
Nombramiento: 10/11/2010

IBERDIAGNOSIS SL

Consejero
Nombramiento: 10/11/2010

IBERDIAGNOSIS SL

Consejero delegado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por PROTON LASER APPLICATIONS SL

30/04/2018 Detalles del anuncio (187552) Datos registrales: T 412 , F 225, S 8, H SA 13616, I/A 12 (16.04.18).

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 741/2017. FIRME: Si, Fecha de resolución 18/10/2017. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 02 DE BARCELONA. Juez: ALBERTO MATA SAIZ.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 741/2017. FIRME: Si, Fecha de resolución 18/10/2017. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 02 DE BARCELONA. Juez: ALBERTO MATA SAIZ.

  • Extinción

25/10/2017 Detalles del anuncio (421512) Datos registrales: T 411 , F 225, S 8, H SA 13616, I/A 11 (10.10.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: HERNANDEZ MUÑOZ MARIA.

  • Nombramientos

    Presidente: PEREZ AZPILLAGA JAVIER.

26/06/2017 Detalles del anuncio (263682) Datos registrales: T 411 , F 224, S 8, H SA 13616, I/A NOTA (29.05.17).

  • Nombramientos

    Auditor: CALLEJA PINILLA CARMEN-MARIA.

29/12/2014 Detalles del anuncio (530841) Datos registrales: T 411 , F 224, S 8, H SA 13616, I/A 9 (16.12.14).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 980,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.980,00 Euros.

29/12/2014 Detalles del anuncio (530842) Datos registrales: T 411 , F 224, S 8, H SA 13616, I/A 10 (16.12.14).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 1.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 27.000,00 Euros.

12/04/2012 Detalles del anuncio (165039) Datos registrales: T 411 , F 156, S 8, H SA 13616, I/A 7 (30.03.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ENGIND SL. Secretario: ENGIND SL. Con.Delegado: ENGIND SL. Presidente: VOCES SANCHEZ FELIPE.

  • Nombramientos

    Consejero: PRODEL 2011 SL. Secretario: PRODEL 2011 SL. Consejero: GALAN VALIENTE MIGUEL;PEREZ AZPILLAGA JAVIER. Presidente: HERNANDEZ MUÑOZ MARIA. Con.Delegado: PRODEL 2011 SL. Vicepresid.: VOCES SANCHEZ FELIPE.

12/04/2012 Detalles del anuncio (165040) Datos registrales: T 411 , F 156, S 8, H SA 13616, I/A 8 (30.03.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: VOCES SANCHEZ FELIPE.

27/12/2011 Detalles del anuncio (517516) Datos registrales: T 411 , F 155, S 8, H SA 13616, I/A 5 (13.12.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: HERNANDEZ MUÑOZ MARIA. Consejero: SAUS MAS VICENTE. Secretario: SAUS MAS VICENTE. Vicepresid.: VOCES SANCHEZ FELIPE. Con.Delegado: SAUS MAS VICENTE.

  • Nombramientos

    Consejero: ENGIND SL. Secretario: ENGIND SL. Con.Delegado: ENGIND SL. Presidente: VOCES SANCHEZ FELIPE.

27/12/2011 Detalles del anuncio (517517) Datos registrales: T 411 , F 155, S 8, H SA 13616, I/A 6 (13.12.11).

  • Revocaciones

    Apoderado: VOCES SANCHEZ FELIPE.

13/10/2011 Detalles del anuncio (800105)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2011) Año: 2010

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 14

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2018-83-37 30/04/2018 Salamanca Descargar
BORME-A-2017-204-37 25/10/2017 Salamanca Descargar
BORME-A-2017-119-37 26/06/2017 Salamanca Descargar
BORME-A-2014-247-37 29/12/2014 Salamanca Descargar
BORME-A-2014-247-37 29/12/2014 Salamanca Descargar
BORME-A-2012-70-37 12/04/2012 Salamanca Descargar
BORME-A-2012-70-37 12/04/2012 Salamanca Descargar
BORME-A-2011-244-37 27/12/2011 Salamanca Descargar
BORME-A-2011-244-37 27/12/2011 Salamanca Descargar
BORME-B-2011-195-37 13/10/2011 Salamanca Descargar