OCIOPOLIS SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 04/01/2018 | MONTORO ALEMAN ANTONIO |
Consejero |
| Cese: 04/01/2018 | MONTORO ALEMAN RICARDO |
Consejero |
| Cese: 04/01/2018 | MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS |
Consejero |
| Cese: 04/01/2018 | MONTORO ALEMAN ANTONIO |
Vicepresidente |
| Cese: 04/01/2018 | MONTORO ALEMAN RICARDO |
Presidente |
| Cese: 04/01/2018 | MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS |
Consejero delegado |
| Cese: 04/01/2018 | GIL PEREZ CARRO ANTONIO |
Secretario no consejero |
| Cese: 04/01/2018 | VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES |
Vicesecretario no consejero |
| Nombramiento: 04/01/2018 | MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS |
Liquidador |
| Cese: 20/07/2017 | ALEMAN PICATOSTE GLORIA |
Consejero |
| Cese: 20/07/2017 | ALEMAN PICATOSTE GLORIA |
Presidente |
| Cese: 20/07/2017 | MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS |
Vicepresidente |
| Cese: 20/07/2017 | MONTORO ALEMAN RICARDO |
Vicepresidente |
| Cese: 20/07/2017 | ALEMAN PICATOSTE GLORIA |
Apoderado |
| Nombramiento: 20/07/2017 | MONTORO ALEMAN RICARDO |
Presidente |
| Nombramiento: 20/07/2017 | MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS |
Consejero delegado |
| Cese: 18/08/2015 | MONTORO ALEMAN MARTA |
Consejero |
| Cese: 18/07/2014 | VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES |
Secretario no consejero |
| Cese: 18/07/2014 | MERCHAN FERNANDEZ MAIRENA |
Vicesecretario no consejero |
| Nombramiento: 18/07/2014 | GIL PEREZ CARRO ANTONIO |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 18/07/2014 | VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES |
Vicesecretario no consejero |
| Nombramiento: 21/11/2013 | GARCIA DE LA CALLE JOSE LUIS |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 21/11/2013 | GIL PEREZ CARRO ANTONIO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 21/11/2013 | BARRONDO AGUDIN XAVIER |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 06/06/2013 | VEGA SORROSAL LUIS |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 06/06/2013 | VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES |
Secretario no consejero |
| Cese: 29/05/2013 | VEGA SORROSAL LUIS |
Apoderado |
| Cese: 29/05/2013 | DEL RINCON GARCIA JUAN ANTONIO |
Apoderado |
| Cese: 29/05/2013 | MONTORO MUÑOZ FRANCISCO |
Consejero |
| Cese: 29/05/2013 | MONTORO MUÑOZ FRANCISCO |
Presidente |
| Cese: 29/05/2013 | ALEMAN PICATOSTE GLORIA |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 29/05/2013 | ALEMAN PICATOSTE GLORIA |
Presidente |
| Nombramiento: 29/05/2013 | MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 29/05/2013 | MONTORO ALEMAN RICARDO |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 29/05/2013 | MONTORO ALEMAN ANTONIO |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 29/05/2013 | GARCIA DE LA CALLE JOSE LUIS |
Apoderado |
| Nombramiento: 07/02/2012 | MONTORO ALEMAN ANTONIO |
Apoderado |
| Nombramiento: 07/02/2012 | MONTORO ALEMAN RICARDO |
Apoderado |
| Nombramiento: 07/02/2012 | VALIENTE CALVO DIEGO |
Apoderado |
| Nombramiento: 07/02/2012 | GARCIA GALERA JUAN |
Apoderado |
| Nombramiento: 07/02/2012 | LLANES GOMEZ SILVIA |
Apoderado |
| Nombramiento: 07/02/2012 | VEGA SORROSAL LUIS |
Apoderado |
| Nombramiento: 07/02/2012 | CALVO SANCHEZ JORGE |
Apoderado |
| Nombramiento: 07/02/2012 | DEL RINCON GARCIA JUAN ANTONIO |
Apoderado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por OCIOPOLIS SL
04/01/2018 Detalles del anuncio (5921) Datos registrales: T 31112 , F 20, S 8, H M 223510, I/A 36 (27.12.17).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: MONTORO ALEMAN ANTONIO;MONTORO ALEMAN RICARDO;MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS. Vicepresid.: MONTORO ALEMAN ANTONIO. Presidente: MONTORO ALEMAN RICARDO. Con.Delegado: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS. SecreNoConsj: GIL PEREZ CARRO ANTONIO. VsecrNoConsj: VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES.
- Nombramientos
Liquidador: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS.
- Disolución
Voluntaria.
- Extinción
20/07/2017 Detalles del anuncio (298528) Datos registrales: T 31112 , F 20, S 8, H M 223510, I/A 35 (13.07.17).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: ALEMAN PICATOSTE GLORIA. Presidente: ALEMAN PICATOSTE GLORIA. Vicepresid.: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS;MONTORO ALEMAN RICARDO.
- Revocaciones
Apoderado: ALEMAN PICATOSTE GLORIA.
- Nombramientos
Presidente: MONTORO ALEMAN RICARDO.
- Reelecciones
Con.Delegado: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS.
10/05/2017 Detalles del anuncio (196525) Datos registrales: T 31112 , F 19, S 8, H M 223510, I/A 34 (28.04.17).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 5.944.515,04 Euros. Resultante Suscrito: 21.953.243,86 Euros.
- Reducción de Capital
Importe reducción: 21.500.005,72 Euros. Resultante Suscrito: 453.238,14 Euros.
18/08/2015 Detalles del anuncio (342751) Datos registrales: T 31112 , F 19, S 8, H M 223510, I/A 33 ( 5.08.15).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: MONTORO ALEMAN MARTA.
18/07/2014 Detalles del anuncio (298058) Datos registrales: T 31112 , F 18, S 8, H M 223510, I/A 32 (11.07.14).
- Ceses/Dimisiones
SecreNoConsj: VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES. VsecrNoConsj: MERCHAN FERNANDEZ MAIRENA.
- Nombramientos
SecreNoConsj: GIL PEREZ CARRO ANTONIO. VsecrNoConsj: VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES.
21/11/2013 Detalles del anuncio (497507) Datos registrales: T 31112 , F 16, S 8, H M 223510, I/A 31 (13.11.13).
- Nombramientos
Apo.Man.Soli: GARCIA DE LA CALLE JOSE LUIS;GIL PEREZ CARRO ANTONIO;BARRONDO AGUDIN XAVIER.
06/06/2013 Detalles del anuncio (259727) Datos registrales: T 20532 , F 109, S 8, H M 223510, I/A 30 (22.05.13).
- Ceses/Dimisiones
SecreNoConsj: VEGA SORROSAL LUIS.
- Nombramientos
SecreNoConsj: VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES.
29/05/2013 Detalles del anuncio (246815) Datos registrales: T 20532 , F 106, S 8, H M 223510, I/A 28 (21.05.13).
- Revocaciones
Apoderado: VEGA SORROSAL LUIS;DEL RINCON GARCIA JUAN ANTONIO.
29/05/2013 Detalles del anuncio (246814) Datos registrales: T 20532 , F 106, S 8, H M 223510, I/A 27 (21.05.13).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: MONTORO MUÑOZ FRANCISCO. Presidente: MONTORO MUÑOZ FRANCISCO. Vicepresid.: ALEMAN PICATOSTE GLORIA.
- Nombramientos
Presidente: ALEMAN PICATOSTE GLORIA. Vicepresid.: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS;MONTORO ALEMAN RICARDO;MONTORO ALEMAN ANTONIO.
29/05/2013 Detalles del anuncio (246816) Datos registrales: T 20532 , F 107, S 8, H M 223510, I/A 29 (21.05.13).
- Nombramientos
Apoderado: GARCIA DE LA CALLE JOSE LUIS.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 18
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2018-3-28 | 04/01/2018 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-137-28 | 20/07/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-87-28 | 10/05/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-156-28 | 18/08/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-135-28 | 18/07/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-223-28 | 21/11/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-105-28 | 06/06/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-99-28 | 29/05/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-99-28 | 29/05/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-99-28 | 29/05/2013 | Madrid | Descargar |