OCIOPOLIS SL

Extinta

CALLE LUCHANA, 23
Madrid  (28010)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 04/01/2018

MONTORO ALEMAN ANTONIO

Consejero
Cese: 04/01/2018

MONTORO ALEMAN RICARDO

Consejero
Cese: 04/01/2018

MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS

Consejero
Cese: 04/01/2018

MONTORO ALEMAN ANTONIO

Vicepresidente
Cese: 04/01/2018

MONTORO ALEMAN RICARDO

Presidente
Cese: 04/01/2018

MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS

Consejero delegado
Cese: 04/01/2018

GIL PEREZ CARRO ANTONIO

Secretario no consejero
Cese: 04/01/2018

VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 04/01/2018

MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS

Liquidador
Cese: 20/07/2017

ALEMAN PICATOSTE GLORIA

Consejero
Cese: 20/07/2017

ALEMAN PICATOSTE GLORIA

Presidente
Cese: 20/07/2017

MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS

Vicepresidente
Cese: 20/07/2017

MONTORO ALEMAN RICARDO

Vicepresidente
Cese: 20/07/2017

ALEMAN PICATOSTE GLORIA

Apoderado
Nombramiento: 20/07/2017

MONTORO ALEMAN RICARDO

Presidente
Nombramiento: 20/07/2017

MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS

Consejero delegado
Cese: 18/08/2015

MONTORO ALEMAN MARTA

Consejero
Cese: 18/07/2014

VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES

Secretario no consejero
Cese: 18/07/2014

MERCHAN FERNANDEZ MAIRENA

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 18/07/2014

GIL PEREZ CARRO ANTONIO

Secretario no consejero
Nombramiento: 18/07/2014

VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 21/11/2013

GARCIA DE LA CALLE JOSE LUIS

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 21/11/2013

GIL PEREZ CARRO ANTONIO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 21/11/2013

BARRONDO AGUDIN XAVIER

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 06/06/2013

VEGA SORROSAL LUIS

Secretario no consejero
Nombramiento: 06/06/2013

VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES

Secretario no consejero
Cese: 29/05/2013

VEGA SORROSAL LUIS

Apoderado
Cese: 29/05/2013

DEL RINCON GARCIA JUAN ANTONIO

Apoderado
Cese: 29/05/2013

MONTORO MUÑOZ FRANCISCO

Consejero
Cese: 29/05/2013

MONTORO MUÑOZ FRANCISCO

Presidente
Cese: 29/05/2013

ALEMAN PICATOSTE GLORIA

Vicepresidente
Nombramiento: 29/05/2013

ALEMAN PICATOSTE GLORIA

Presidente
Nombramiento: 29/05/2013

MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS

Vicepresidente
Nombramiento: 29/05/2013

MONTORO ALEMAN RICARDO

Vicepresidente
Nombramiento: 29/05/2013

MONTORO ALEMAN ANTONIO

Vicepresidente
Nombramiento: 29/05/2013

GARCIA DE LA CALLE JOSE LUIS

Apoderado
Nombramiento: 07/02/2012

MONTORO ALEMAN ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 07/02/2012

MONTORO ALEMAN RICARDO

Apoderado
Nombramiento: 07/02/2012

VALIENTE CALVO DIEGO

Apoderado
Nombramiento: 07/02/2012

GARCIA GALERA JUAN

Apoderado
Nombramiento: 07/02/2012

LLANES GOMEZ SILVIA

Apoderado
Nombramiento: 07/02/2012

VEGA SORROSAL LUIS

Apoderado
Nombramiento: 07/02/2012

CALVO SANCHEZ JORGE

Apoderado
Nombramiento: 07/02/2012

DEL RINCON GARCIA JUAN ANTONIO

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por OCIOPOLIS SL

04/01/2018 Detalles del anuncio (5921) Datos registrales: T 31112 , F 20, S 8, H M 223510, I/A 36 (27.12.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MONTORO ALEMAN ANTONIO;MONTORO ALEMAN RICARDO;MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS. Vicepresid.: MONTORO ALEMAN ANTONIO. Presidente: MONTORO ALEMAN RICARDO. Con.Delegado: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS. SecreNoConsj: GIL PEREZ CARRO ANTONIO. VsecrNoConsj: VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES.

  • Nombramientos

    Liquidador: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

20/07/2017 Detalles del anuncio (298528) Datos registrales: T 31112 , F 20, S 8, H M 223510, I/A 35 (13.07.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ALEMAN PICATOSTE GLORIA. Presidente: ALEMAN PICATOSTE GLORIA. Vicepresid.: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS;MONTORO ALEMAN RICARDO.

  • Revocaciones

    Apoderado: ALEMAN PICATOSTE GLORIA.

  • Nombramientos

    Presidente: MONTORO ALEMAN RICARDO.

  • Reelecciones

    Con.Delegado: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS.

10/05/2017 Detalles del anuncio (196525) Datos registrales: T 31112 , F 19, S 8, H M 223510, I/A 34 (28.04.17).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 5.944.515,04 Euros. Resultante Suscrito: 21.953.243,86 Euros.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 21.500.005,72 Euros. Resultante Suscrito: 453.238,14 Euros.

18/08/2015 Detalles del anuncio (342751) Datos registrales: T 31112 , F 19, S 8, H M 223510, I/A 33 ( 5.08.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MONTORO ALEMAN MARTA.

18/07/2014 Detalles del anuncio (298058) Datos registrales: T 31112 , F 18, S 8, H M 223510, I/A 32 (11.07.14).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES. VsecrNoConsj: MERCHAN FERNANDEZ MAIRENA.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: GIL PEREZ CARRO ANTONIO. VsecrNoConsj: VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES.

21/11/2013 Detalles del anuncio (497507) Datos registrales: T 31112 , F 16, S 8, H M 223510, I/A 31 (13.11.13).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: GARCIA DE LA CALLE JOSE LUIS;GIL PEREZ CARRO ANTONIO;BARRONDO AGUDIN XAVIER.

06/06/2013 Detalles del anuncio (259727) Datos registrales: T 20532 , F 109, S 8, H M 223510, I/A 30 (22.05.13).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: VEGA SORROSAL LUIS.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES.

29/05/2013 Detalles del anuncio (246815) Datos registrales: T 20532 , F 106, S 8, H M 223510, I/A 28 (21.05.13).

  • Revocaciones

    Apoderado: VEGA SORROSAL LUIS;DEL RINCON GARCIA JUAN ANTONIO.

29/05/2013 Detalles del anuncio (246814) Datos registrales: T 20532 , F 106, S 8, H M 223510, I/A 27 (21.05.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MONTORO MUÑOZ FRANCISCO. Presidente: MONTORO MUÑOZ FRANCISCO. Vicepresid.: ALEMAN PICATOSTE GLORIA.

  • Nombramientos

    Presidente: ALEMAN PICATOSTE GLORIA. Vicepresid.: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS;MONTORO ALEMAN RICARDO;MONTORO ALEMAN ANTONIO.

29/05/2013 Detalles del anuncio (246816) Datos registrales: T 20532 , F 107, S 8, H M 223510, I/A 29 (21.05.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: GARCIA DE LA CALLE JOSE LUIS.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 18

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2018-3-28 04/01/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-137-28 20/07/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-87-28 10/05/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2015-156-28 18/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-135-28 18/07/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-223-28 21/11/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-105-28 06/06/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-99-28 29/05/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-99-28 29/05/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-99-28 29/05/2013 Madrid Descargar