OCA CORPORATE SERVICES SL

Cambio de denominación social

C/ VIA DE LAS DOS CASTILLAS 7 (POZUELO DE ALARCON).
 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 18/04/2017

RAMON NAVARRO OSCAR

Apoderado solidario
Cese: 16/01/2017

MARTINEZ MARTIN JOAN EDUARD

Apoderado solidario
Cese: 13/07/2015

SAEZ DOMINGO VIRGILIO

Apoderado
Nombramiento: 27/04/2015

PLANAS PENADES ROGER ALBERT

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/07/2014

CHOPO FUSTE MARIA MERCEDES

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/07/2014

FAJULA FARRES RAMON

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/07/2014

FAJULA CHOPO JOSEP

Consejero delegado
Cese: 11/07/2014

FAJULA FARRES RAMON

Administrador solidario
Cese: 11/07/2014

CHOPO FUSTE MERCEDES

Administrador solidario
Nombramiento: 11/07/2014

FAJULA FARRES RAMON

Consejero
Nombramiento: 11/07/2014

FAJULA FARRES RAMON

Presidente
Nombramiento: 11/07/2014

CHOPO FUSTE MERCEDES

Consejero
Nombramiento: 11/07/2014

FAJULA CHOPO JOSEP

Consejero
Nombramiento: 11/07/2014

FAJULA CHOPO JOAQUIM

Consejero
Nombramiento: 11/07/2014

SALAZAR SERRA JOSEP

Secretario no consejero
Nombramiento: 14/11/2013

MARTINEZ MARTIN JOAN EDUARD

Apoderado solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por OCA CORPORATE SERVICES SL

27/07/2018 Detalles del anuncio (313034) Datos registrales: T 36788 , F 172, S 8, H M 658923, I/A 4 (19.07.18).

  • Cambio de denominación social

    OCA GLOBAL INVESTMENTS SL.

26/07/2018 Detalles del anuncio (311170) Datos registrales: T 36788 , F 171, S 8, H M 658923, I/A 3 (19.07.18).

  • Fusión por Absorción

    Sociedades absorbidas: OCA ENTIDAD DE INSPECCION Y CONTROL SA.

18/12/2017 Detalles del anuncio (492242) Datos registrales: T 36788 , F 171, S 8, H M 658923, I/A 2 ( 9.12.17).

  • Cambio de domicilio social

    C/ VIA DE LAS DOS CASTILLAS 7 (POZUELO DE ALARCON).

18/04/2017 Detalles del anuncio (167063) Datos registrales: T 44391 , F 152, S 8, H B 359855, I/A 20 ( 6.04.17).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: RAMON NAVARRO OSCAR.

16/01/2017 Detalles del anuncio (19409) Datos registrales: T 44391 , F 152, S 8, H B 359855, I/A 19 ( 5.01.17).

  • Revocaciones

    APODERAD.SOL: MARTINEZ MARTIN JOAN EDUARD.

13/07/2015 Detalles del anuncio (285473) Datos registrales: T 44391 , F 152, S 8, H B 359855, I/A 18 ( 6.07.15).

  • Revocaciones

    APODERADO: SAEZ DOMINGO VIRGILIO.

19/05/2015 Detalles del anuncio (200110) Datos registrales: T 44391 , F 152, S 8, H B 359855, I/A 17 (11.05.15).

  • Otros Conceptos

    PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL.

27/04/2015 Detalles del anuncio (172084) Datos registrales: T 44391 , F 151, S 8, H B 359855, I/A 16 (17.04.15).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: PLANAS PENADES ROGER ALBERT.

24/07/2014 Detalles del anuncio (304645) Datos registrales: T 43313 , F 120, S 8, H B 359855, I/A 15 (16.07.14).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: CHOPO FUSTE MARIA MERCEDES.

24/07/2014 Detalles del anuncio (304644) Datos registrales: T 43313 , F 118, S 8, H B 359855, I/A 14 (16.07.14).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: FAJULA FARRES RAMON.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 16

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2018-144-28 27/07/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-143-28 26/07/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-238-28 18/12/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-73-08 18/04/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-10-08 16/01/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-130-08 13/07/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-92-08 19/05/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-78-08 27/04/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-139-08 24/07/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-139-08 24/07/2014 Barcelona Descargar