MOLINS CAPITAL INVERSION SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 11/03/2016

FRESNEDO AMADO JOSE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 11/03/2016

CASAS SOGAS JUAN

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 11/03/2016

MATIAS BELLIDO MANUEL

Secretario no consejero
Cese: 11/03/2016

COROMINA MORATO LLUIS

Consejero
Cese: 11/03/2016

ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SL

Consejero
Cese: 11/03/2016

MOLINS GIL JOAQUIN MARIA

Consejero
Cese: 11/03/2016

MOLINS GIL JOAQUIN MARIA

Presidente
Cese: 11/03/2016

CORPORACION INVEX SL

Consejero
Cese: 11/03/2016

ROMERO OLID RAMON

Consejero
Cese: 11/03/2016

ROJAS MIRANDA ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 11/03/2016

ACTIVE VENTURE PARTNERS SGEIC SA

Liquidador
Nombramiento: 11/03/2016

RICARD SODERBERG

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 05/08/2015

VIR AUDIT SLP

Auditor de cuentas
Cese: 05/08/2015

CASA GRANDE DE CARTAGENA SL

Consejero
Cese: 05/08/2015

ROJAS MIRANDA ANTONIO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 05/08/2015

ROMERO OLID RAMON

Consejero
Nombramiento: 05/08/2015

ROJAS MIRANDA ANTONIO

Consejero
Cese: 23/02/2015

VIDAL RIBAS MARTI EUSEBIO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 23/02/2015

ROJAS MIRANDA ANTONIO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 26/12/2014

BASSAL RIERA ALFREDO

Consejero
Cese: 26/12/2014

BASSAL RIERA ALFREDO

Vicepresidente
Nombramiento: 29/10/2014

VIR AUDIT SLP

Auditor de cuentas
Cese: 01/08/2014

MOLINS GIL JOAQUIN

Presidente ejecutivo
Cese: 01/08/2014

IMMO STROHER

Consejero
Nombramiento: 01/08/2014

MOLINS GIL JOAQUIN MARIA

Consejero
Nombramiento: 01/08/2014

BASSAL RIERA ALFREDO

Consejero
Nombramiento: 01/08/2014

CORPORACION INVEX SL

Consejero
Nombramiento: 05/08/2013

COROMINA MORATO LLUIS

Consejero
Nombramiento: 05/08/2013

ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SL

Consejero
Nombramiento: 05/08/2013

CASA GRANDE DE CARTAGENA SL

Consejero
Nombramiento: 26/01/2012

VIR AUDIT SLP

Auditor de cuentas
Nombramiento: 24/10/2011

JIMENEZ LOPEZ YOLANDA

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por MOLINS CAPITAL INVERSION SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA

11/03/2016 Detalles del anuncio (114957) Datos registrales: T 44915 , F 7, S 8, H B 279100, I/A 45 ( 3.03.16).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: FRESNEDO AMADO JOSE;CASAS SOGAS JUAN. SECR.NO CONS: MATIAS BELLIDO MANUEL. CONSEJERO: COROMINA MORATO LLUIS;ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SL;MOLINS GIL JOAQUIN MARIA. PRESIDENTE: MOLINS GIL JOAQUIN MARIA. CONSEJERO: CORPORACION INVEX SL;ROMERO OLID RAMON;ROJAS MIRANDA ANTONIO.

  • Nombramientos

    LIQUIDADOR: ACTIVE VENTURE PARTNERS SGEIC SA. REPR.143 RRM: RICARD SODERBERG.

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1,2,4,5,8,9,22,24,26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE LA RENUNCIA DE LA SOCIEDAD A SU CONDICION DE ENTIDAD DE CAPITAL RIESGO,ADOPTANDO LA DENOMINACION: MOLINS CAPITAL INVERSION SA.

  • Cambio de denominación social

    MOLINS CAPITAL INVERSION SA.

  • Cambio de objeto social

    LA DIRECCION Y GESTION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES RESIDENTES O NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL Y LA COLOCACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES CONSTITUTIVAS ...

  • Disolución

    Voluntaria.

13/11/2015 Detalles del anuncio (456935) Datos registrales: T 43871 , F 54, S 8, H B 279100, I/A 44 ( 4.11.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 210.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.820.000,00 Euros.

05/08/2015 Detalles del anuncio (325108) Datos registrales: T 43871 , F 54, S 8, H B 279100, I/A 43 (28.07.15).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: VIR AUDIT SLP.

05/08/2015 Detalles del anuncio (325106) Datos registrales: T 43871 , F 53, S 8, H B 279100, I/A 42 (28.07.15).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: CASA GRANDE DE CARTAGENA SL. REPR.143 RRM: ROJAS MIRANDA ANTONIO.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: ROMERO OLID RAMON;ROJAS MIRANDA ANTONIO.

02/06/2015 Detalles del anuncio (222686) Datos registrales: T 43871 , F 52, S 8, H B 279100, I/A 41 (26.05.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 1.470.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.030.000,00 Euros.

23/02/2015 Detalles del anuncio (77905) Datos registrales: T 43871 , F 52, S 8, H B 279100, I/A 40 (13.02.15).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: VIDAL RIBAS MARTI EUSEBIO.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: ROJAS MIRANDA ANTONIO.

26/12/2014 Detalles del anuncio (527026) Datos registrales: T 43871 , F 52, S 8, H B 279100, I/A 39 (17.12.14).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: BASSAL RIERA ALFREDO. VICEPRESIDEN: BASSAL RIERA ALFREDO.

29/10/2014 Detalles del anuncio (434882) Datos registrales: T 43871 , F 51, S 8, H B 279100, I/A 38 (21.10.14).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: VIR AUDIT SLP.

01/08/2014 Detalles del anuncio (316482) Datos registrales: T 43871 , F 51, S 8, H B 279100, I/A 37 (24.07.14).

  • Revocaciones

    PRES.EJECUT.: MOLINS GIL JOAQUIN. CONSEJERO: IMMO STROHER.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: MOLINS GIL JOAQUIN MARIA;BASSAL RIERA ALFREDO;CORPORACION INVEX SL.

05/08/2013 Detalles del anuncio (348812) Datos registrales: T 41260 , F 160, S 8, H B 279100, I/A 36 (26.07.13).

  • Nombramientos

    CONSEJERO: COROMINA MORATO LLUIS;ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SL;CASA GRANDE DE CARTAGENA SL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 25

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2016-49-08 11/03/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-217-08 13/11/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-147-08 05/08/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-147-08 05/08/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-102-08 02/06/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-36-08 23/02/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-246-08 26/12/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-207-08 29/10/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-145-08 01/08/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-147-08 05/08/2013 Barcelona Descargar