KVIAR VENTURES SL

Extinta

CL ARIBAU Num.191 P.4 PTA.1 (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 16/06/2022

THOMAS CONLEY ROLLINS JR

Administrador único
Cese: 16/06/2022

FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL

Liquidador
Nombramiento: 16/06/2022

FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL

Liquidador
Cese: 19/11/2019

STEWART MASTERS

Director general
Cese: 19/11/2019

STEWART DUNCAN MASTERS

Apoderado solidario
Cese: 12/07/2019

HUERTAS PAMPIN CRISTINA

Apoderado solidario
Cese: 12/07/2019

LOPEZ GONZALEZ MARIO

Apoderado solidario
Cese: 12/07/2019

VALERO MUÑOZ ROJAS LETICIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 12/07/2019

BROSA MIRO JAIME

Apoderado solidario
Nombramiento: 12/07/2019

BROSA MIRO MARTA

Apoderado solidario
Cese: 21/06/2019

CHARLES ANTONY SEFI

Administrador único
Nombramiento: 21/06/2019

THOMAS CONLEY ROLLINS JR

Administrador único
Nombramiento: 13/07/2018

STEWART DUNCAN MASTERS

Apoderado solidario
Cese: 02/07/2018

CHRISTOPHER FUCHS

Consejero
Cese: 02/07/2018

CHRISTOPHER FUCHS

Presidente
Cese: 02/07/2018

STEWART MASTERS

Consejero
Cese: 02/07/2018

STEWART MASTERS

Secretario
Cese: 02/07/2018

CEBRIAN PEREZ YARZA GONZALO

Consejero
Cese: 02/07/2018

SANCHEZ MARTINEZ ALVARO

Consejero
Cese: 02/07/2018

EVOLVIA SA

Consejero
Cese: 02/07/2018

VILLENA CONTRERAS LUIS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 02/07/2018

MAYOL DE TORD PERE

Consejero
Cese: 02/07/2018

JAN BRINCHMANN

Consejero
Cese: 02/07/2018

URIARTE INCHAUSTI RAMON

Consejero
Cese: 02/07/2018

ROY PEREZ JORGE

Consejero
Nombramiento: 02/07/2018

CHARLES ANTONY SEFI

Administrador único
Nombramiento: 24/07/2015

HUERTAS PAMPIN CRISTINA

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/07/2015

LOPEZ GONZALEZ MARIO

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/07/2015

VALERO MUÑOZ ROJAS LETICIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 22/05/2015

STEWART MASTERS

Director general
Cese: 23/04/2015

CHRISTOPHER FUCHS

Consejero delegado
Cese: 07/03/2014

CEBRIAN PEREZ-YARZA GONZALO PORFIRIO

Administrador solidario
Cese: 07/03/2014

FUCHS CHRISTOPHER PAUL

Administrador solidario
Nombramiento: 07/03/2014

VILLENA CONTRERAS LUIS

Representante
Nombramiento: 07/03/2014

FUCHS CHRISTOPHER

Consejero
Nombramiento: 07/03/2014

MASTERS STEWART

Consejero
Nombramiento: 07/03/2014

CEBRIAN PEREZ-YARZA GONZALO

Consejero
Nombramiento: 07/03/2014

SANCHEZ MARTINEZ ALVARO

Consejero
Nombramiento: 07/03/2014

EVOLVIA SA

Consejero
Nombramiento: 07/03/2014

MAYOL DE TORD PERE

Consejero
Nombramiento: 07/03/2014

BRINCKMANN JAN

Consejero
Nombramiento: 07/03/2014

URIARTE INCHAUSTI RAMON

Consejero
Nombramiento: 07/03/2014

ROY PEREZ JORGE

Consejero
Nombramiento: 07/03/2014

FUCHS CHRISTOPHER

Presidente
Nombramiento: 07/03/2014

MASTERS STEWART

Secretario
Nombramiento: 07/03/2014

FUCHS CHRISTOPHER

Consejero delegado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por KVIAR VENTURES SL

16/06/2022 Detalles del anuncio (280580) Datos registrales: T 44756 , F 50, S 8, H B 465516, I/A 17 ( 9.06.22).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: THOMAS CONLEY ROLLINS JR. LIQUIDADOR: FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL.

  • Nombramientos

    LIQUIDADOR: FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL.

  • Extinción

19/11/2019 Detalles del anuncio (476658) Datos registrales: T 44756 , F 49, S 8, H B 465516, I/A 16 (11.11.19).

  • Revocaciones

    DTOR.GENERAL: STEWART MASTERS. APODERAD.SOL: STEWART DUNCAN MASTERS.

12/07/2019 Detalles del anuncio (300273) Datos registrales: T 44756 , F 49, S 8, H B 465516, I/A 15 ( 4.07.19).

  • Revocaciones

    APODERAD.SOL: HUERTAS PAMPIN CRISTINA;LOPEZ GONZALEZ MARIO;VALERO MUÑOZ ROJAS LETICIA.

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: BROSA MIRO JAIME;BROSA MIRO MARTA.

26/06/2019 Detalles del anuncio (276645) Datos registrales: T 44756 , F 49, S 8, H B 465516, I/A 14 (18.06.19).

  • Cambio de domicilio social

    CL ARIBAU Num.191 P.4 PTA.1 (BARCELONA).

21/06/2019 Detalles del anuncio (270267) Datos registrales: T 44756 , F 49, S 8, H B 465516, I/A 13 (13.06.19).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: CHARLES ANTONY SEFI.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: THOMAS CONLEY ROLLINS JR.

13/07/2018 Detalles del anuncio (291650) Datos registrales: T 44756 , F 49, S 8, H B 465516, I/A 12 ( 5.07.18).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: STEWART DUNCAN MASTERS.

02/07/2018 Detalles del anuncio (274899) Datos registrales: T 44756 , F 48, S 8, H B 465516, I/A 11 (25.06.18).

  • Otros Conceptos

    DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: RESY NETWORK INC.

02/07/2018 Detalles del anuncio (274898) Datos registrales: T 44756 , F 48, S 8, H B 465516, I/A 10 (25.06.18).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: CHRISTOPHER FUCHS. PRESIDENTE: CHRISTOPHER FUCHS. CONSEJERO: STEWART MASTERS. SECRETARIO: STEWART MASTERS. CONSEJERO: CEBRIAN PEREZ YARZA GONZALO;SANCHEZ MARTINEZ ALVARO;EVOLVIA SA. REPR.143 RRM: VILLENA CONTRERAS LUIS. CONSEJERO: MAYOL DE TORD PERE;JAN BRINCHMANN;URIARTE INCHAUSTI RAMON;ROY PEREZ JORGE.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: CHARLES ANTONY SEFI.

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 14 Y 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.

24/07/2015 Detalles del anuncio (306361) Datos registrales: T 44756 , F 47, S 8, H B 465516, I/A 9 (15.07.15).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: HUERTAS PAMPIN CRISTINA;LOPEZ GONZALEZ MARIO;VALERO MUÑOZ ROJAS LETICIA.

22/05/2015 Detalles del anuncio (206288) Datos registrales: T 44756 , F 44, S 8, H B 465516, I/A 8 (14.05.15).

  • Nombramientos

    DTOR.GENERAL: STEWART MASTERS.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 17

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-114-08 16/06/2022 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-222-08 19/11/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-132-08 12/07/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-120-08 26/06/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-117-08 21/06/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-134-08 13/07/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-125-08 02/07/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-125-08 02/07/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-139-08 24/07/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-95-08 22/05/2015 Barcelona Descargar