GESTIO CASA JOVE SL

Extinta

CL TENERIFE Num.44 P.1 (SABADELL).
 Sabadell, Barcelona
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 04/11/2016

ARRELS SERVEIS I GESTIO SL

Liquidador
Cese: 04/11/2016

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 04/11/2016

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Administrador único
Cese: 12/08/2015

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Administrador único
Nombramiento: 12/08/2015

ARRELS SERVEIS I GESTIO SL

Liquidador
Nombramiento: 12/08/2015

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 26/06/2015

ENCUENTRA MARTINEZ LLUIS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 26/06/2015

GALANTE GALANTE JOSE LUIS

Consejero
Cese: 26/06/2015

PRESTON FOSTER SL

Consejero
Cese: 26/06/2015

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Consejero
Cese: 26/06/2015

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Presidente
Cese: 26/06/2015

PRESTON FOSTER SL

Secretario
Nombramiento: 26/06/2015

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Administrador único
Nombramiento: 18/02/2015

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 18/02/2015

ENCUENTRA MARTINEZ LUIS

Apoderado solidario mancomunado
Cese: 09/02/2015

ARRAHONA IMMO SL

Consejero
Cese: 09/02/2015

ARRAHONA IMMO SL

Secretario
Cese: 09/02/2015

MOMBLAN GRIMA FRANCISCO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 09/02/2015

PRESTON FOSTER SL

Secretario
Cese: 16/12/2014

GIL SANCHIS PERE

Apoderado
Cese: 16/12/2014

MORETTI RODRIGUEZ CECILIA RENEE

Apoderado
Cese: 16/12/2014

LOPEZ SANVICENS ALBERT

Apoderado
Cese: 16/12/2014

GUAL GARCIA ROSA ANA

Apoderado
Cese: 16/12/2014

PALAU CONTINENTE SANTIAGO

Apoderado
Cese: 16/12/2014

ESCAMILLA MOS EDUARD

Apoderado
Cese: 16/12/2014

EXPOSITO SANCHEZ JORGE

Apoderado
Cese: 16/12/2014

VICENTE ROCA RAMON

Apoderado
Cese: 16/12/2014

SIMO BAYONA ALBERTO

Apoderado
Cese: 16/12/2014

ROJAS MIRAVETE JOSE IGNACIO

Apoderado
Cese: 16/12/2014

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Apoderado
Cese: 19/03/2014

NAVARRO MATEUS JOSEP JOAN

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 19/03/2014

ENCUENTRA MARTINEZ LLUIS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 29/01/2014

COSP GOMEZ JORDI

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 29/01/2014

MOMBLAN GRIMA FRANCISCO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 17/01/2014

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Consejero
Cese: 23/05/2012

EXPOSITO SANCHEZ JORGE

Consejero
Cese: 23/05/2012

SIMO BAYONA ALBERTO

Consejero
Cese: 23/05/2012

EXPOSITO SANCHEZ JORGE

Presidente
Cese: 23/05/2012

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Secretario
Nombramiento: 23/05/2012

GALANTE GALANTE JOSE LUIS

Consejero
Nombramiento: 23/05/2012

ARRAHONA IMMO SL

Consejero
Nombramiento: 23/05/2012

ARRAHONA IMMO SL

Secretario
Nombramiento: 23/05/2012

COSP GOMEZ JORDI

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 23/05/2012

PRESTON FOSTER SL

Consejero
Nombramiento: 23/05/2012

NAVARRO MATEUS JOSEP JOAN

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 23/05/2012

HERRERO DIAZ FRANCISCO

Presidente

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por GESTIO CASA JOVE SL

09/12/2022 Detalles del anuncio (537091) Datos registrales: T 44127 , F 207, S 8, H B 365656, I/A 22 (29.11.22).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 185.219,00 Euros. Resultante Suscrito: 185.219,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 805,30 Euros. Resultante Suscrito: 186.024,30 Euros.

20/01/2017 Detalles del anuncio (30700) Datos registrales: T 44127 , F 207, S 8, H B 365656, I/A 21 (12.01.17).

  • Otros Conceptos

    PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL.

04/11/2016 Detalles del anuncio (444760) Datos registrales: T 44127 , F 207, S 8, H B 365656, I/A 20 (26.10.16).

  • Revocaciones

    LIQUIDADOR: ARRELS SERVEIS I GESTIO SL. REPR.143 RRM: HERRERO DIAZ FRANCISCO.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: HERRERO DIAZ FRANCISCO.

  • Otros Conceptos

    REACTIVACION DE LA SOCIEDAD POR ACUERDO DE JUNTA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2016.

12/08/2015 Detalles del anuncio (334571) Datos registrales: T 44127 , F 206, S 8, H B 365656, I/A 19 ( 4.08.15).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: HERRERO DIAZ FRANCISCO.

  • Nombramientos

    LIQUIDADOR: ARRELS SERVEIS I GESTIO SL. REPR.143 RRM: HERRERO DIAZ FRANCISCO.

  • Otros Conceptos

    SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: ARRELS JOVE SL.

  • Disolución

    Voluntaria.

26/06/2015 Detalles del anuncio (263333) Datos registrales: T 44127 , F 206, S 8, H B 365656, I/A 18 (18.06.15).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: ENCUENTRA MARTINEZ LLUIS. CONSEJERO: GALANTE GALANTE JOSE LUIS;PRESTON FOSTER SL;HERRERO DIAZ FRANCISCO. PRESIDENTE: HERRERO DIAZ FRANCISCO. SECRETARIO: PRESTON FOSTER SL.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: HERRERO DIAZ FRANCISCO.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 185.219,00 Euros. Resultante Suscrito: 370.438,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    ART.8.ORGANOS DE LA SOCIEDAD.- ART.16.MODO DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACION.

18/02/2015 Detalles del anuncio (71790) Datos registrales: T 44127 , F 204, S 8, H B 365656, I/A 17 (10.02.15).

  • Nombramientos

    APOD.SOL/MAN: HERRERO DIAZ FRANCISCO;ENCUENTRA MARTINEZ LUIS.

09/02/2015 Detalles del anuncio (55212) Datos registrales: T 44127 , F 203, S 8, H B 365656, I/A 16 (29.01.15).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: ARRAHONA IMMO SL. SECRETARIO: ARRAHONA IMMO SL. REPR.143 RRM: MOMBLAN GRIMA FRANCISCO.

  • Nombramientos

    SECRETARIO: PRESTON FOSTER SL.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 249.643,00 Euros. Resultante Suscrito: 555.657,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    ARTICULO 16: MODO DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACION.

15/01/2015 Detalles del anuncio (12832) Datos registrales: T 44127 , F 202, S 8, H B 365656, I/A 15 ( 7.01.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 594.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 805.300,00 Euros.

16/12/2014 Detalles del anuncio (510520) Datos registrales: T 44127 , F 202, S 8, H B 365656, I/A 14 ( 4.12.14).

  • Revocaciones

    APODERADO: GIL SANCHIS PERE;MORETTI RODRIGUEZ CECILIA RENEE;LOPEZ SANVICENS ALBERT;GUAL GARCIA ROSA ANA;PALAU CONTINENTE SANTIAGO;ESCAMILLA MOS EDUARD;EXPOSITO SANCHEZ JORGE;VICENTE ROCA RAMON;SIMO BAYONA ALBERTO;ROJAS MIRAVETE JOSE IGNACIO;HERRERO DIAZ FRANCISCO.

04/08/2014 Detalles del anuncio (318654) Datos registrales: T 44127 , F 202, S 8, H B 365656, I/A 13 (25.07.14).

  • Cambio de domicilio social

    CL TENERIFE Num.44 P.1 (SABADELL).

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 22

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-233-08 09/12/2022 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-14-08 20/01/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-211-08 04/11/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-152-08 12/08/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-119-08 26/06/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-33-08 18/02/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-26-08 09/02/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-9-08 15/01/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-239-08 16/12/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-146-08 04/08/2014 Barcelona Descargar