GESOAR SL

Extinta

PASEO SALAMANCA, 1 - C PLT 1
 San Andrés del Rabanedo, León  (24009)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 23/09/2022

NEIDUX SA EN LIQUIDACION

Administrador mancomunado
Cese: 23/09/2022

ALVAREZ CORTIÑAS PABLO

Administrador mancomunado
Cese: 23/09/2022

RUBIO GARCES FRANCISCO

Representante
Nombramiento: 23/09/2022

NEIDUX SA EN LIQUIDACION

Liquidador mancomunado
Nombramiento: 23/09/2022

CONSTRUCCIONES CARRIEGOS SA

Liquidador mancomunado
Nombramiento: 23/09/2022

RUBIO GARCES FRANCISCO

Representante
Nombramiento: 23/09/2022

DE LA FUENTE CABERO FAUSTINO

Representante
Cese: 07/03/2022

DIAZ SANCHEZ BRAVO JAVIER

Representante
Nombramiento: 07/03/2022

RUBIO GARCES FRANCISCO

Representante
Cese: 06/04/2010

AGUILAR LOPEZ JUAN MARIA

Representante
Nombramiento: 06/04/2010

DIAZ SANCHEZ BRAVO JAVIER

Representante

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por GESOAR SL

23/09/2022 Detalles del anuncio (425217) Datos registrales: T 11496 , F 164, S 8, H M 180499, I/A 13 (16.09.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: NEIDUX SA EN LIQUIDACION;ALVAREZ CORTIÑAS PABLO. Representan: RUBIO GARCES FRANCISCO.

  • Nombramientos

    Liquidador M: NEIDUX SA EN LIQUIDACION;CONSTRUCCIONES CARRIEGOS SA. Representan: RUBIO GARCES FRANCISCO;DE LA FUENTE CABERO FAUSTINO.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

07/03/2022 Detalles del anuncio (100736) Datos registrales: T 11496 , F 164, S 8, H M 180499, I/A 12 (28.02.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: DIAZ SANCHEZ BRAVO JAVIER.

  • Nombramientos

    Representan: RUBIO GARCES FRANCISCO.

04/06/2014 Detalles del anuncio (235061) Datos registrales: T 11496 , F 164, S 8, H M 180499, I/A 11 (27.05.14).

  • Modificaciones Estatutarias

    Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12.

24/12/2010 Detalles del anuncio (1177483)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Diciembre de 2010) Año: 2010

06/04/2010 Detalles del anuncio (138314) Datos registrales: T 11496 , F 163, S 8, H M 180499, I/A 10 (24.03.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: AGUILAR LOPEZ JUAN MARIA.

  • Nombramientos

    Representan: DIAZ SANCHEZ BRAVO JAVIER.

31/03/2010 Detalles del anuncio (146131)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Marzo de 2010) Año: 2009

09/10/2009 Detalles del anuncio (630936)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2009) Año: 2008

06/05/2009 Detalles del anuncio (210550) Datos registrales: T 11496 , F 163, S 8, H M 180499, I/A 9 (22.04.09).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 29. Cierre del Ejercicio.-.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 8

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-183-28 23/09/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-45-28 07/03/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2014-104-28 04/06/2014 Madrid Descargar
BORME-B-2010-245-28 24/12/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-63-28 06/04/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2010-61-28 31/03/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2009-194-28 09/10/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-84-28 06/05/2009 Madrid Descargar