FADERS SA

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 07/03/2019

ALHOS CONCURSAL SLP

Administrador concurs.
Cese: 07/03/2019

PUIGVERT IBARS JOSE

Representante administrador concurs.
Cese: 14/05/2015

DISPUR SL

Administrador único
Cese: 14/05/2015

PLANES CORTS EULALIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 16/01/2015

ALHOS CONCURSAL SLP

Administrador concurs.
Nombramiento: 16/01/2015

PUIGVERT IBARS JOSE

Representante administrador concurs.
Cese: 28/04/2014

JOVE ARRUEBO SUSANA CONCEPCION

Apoderado
Cese: 22/05/2009

CIRERA NOGUERAS JOSE ALBERTO

Apoderado
Cese: 03/04/2009

DISPUR SL

Consejero
Cese: 03/04/2009

DISPUR SL

Presidente
Cese: 03/04/2009

RISK 2002 SL

Consejero
Cese: 03/04/2009

RISK 2002 SL

Vicepresidente
Cese: 03/04/2009

ALTERNATIVA SERVICIOS RESIDENCIALES SL

Consejero
Cese: 03/04/2009

PLANES CORTS EULALIA

Consejero
Cese: 03/04/2009

PLANES CORTS EULALIA

Secretario
Cese: 03/04/2009

PLANES VILA JUAN

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 03/04/2009

CIRERA NOGUERAS JOSE ALBERTO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 03/04/2009

CIRERA NOGUERAS ANTONIO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 03/04/2009

DISPUR SL

Administrador único
Nombramiento: 03/04/2009

PLANES CORTS EULALIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 25/03/2009

JOVE ARRUEBO SUSANA CONCEPCION

Apoderado
Nombramiento: 25/03/2009

DOMINGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por FADERS SA

07/03/2019 Detalles del anuncio (105645) Datos registrales: T 41112 , F 134, S 8, H B 40372, I/A 36 (28.02.19).

  • Revocaciones

    ADM.CONCURS.: ALHOS CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: PUIGVERT IBARS JOSE.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 810/2014, AUTO FIRME DE FECHA 25/01/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.

  • Extinción

07/11/2016 Detalles del anuncio (446937) Datos registrales: T 41112 , F 133, S 8, H B 40372, I/A 35 (31.10.16).

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 810/2014, AUTO FIRME DE FECHA 29/07/2016, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION.

14/05/2015 Detalles del anuncio (195516) Datos registrales: T 41112 , F 133, S 8, H B 40372, I/A 34 ( 7.05.15).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: DISPUR SL. REPR.143 RRM: PLANES CORTS EULALIA.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 810/2014, AUTO FIRME DE FECHA 28/01/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

  • Disolución

    Judicial.

16/01/2015 Detalles del anuncio (15545) Datos registrales: T 41112 , F 132, S 8, H B 40372, I/A 33 ( 8.01.15).

  • Nombramientos

    ADM.CONCURS.: ALHOS CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: PUIGVERT IBARS JOSE.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 810/2014, AUTO FIRME DE FECHA 30/10/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.

28/04/2014 Detalles del anuncio (181129) Datos registrales: T 41112 , F 132, S 8, H B 40372, I/A 32 (16.04.14).

  • Revocaciones

    APODERADO: JOVE ARRUEBO SUSANA CONCEPCION.

06/10/2011 Detalles del anuncio (710961)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

29/10/2010 Detalles del anuncio (924971)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2010) Año: 2009

26/10/2009 Detalles del anuncio (739298)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2009) Año: 2008

15/06/2009 Detalles del anuncio (266545) Datos registrales: T 41112 , F 131, S 8, H B 40372, I/A 31 ( 2.06.09).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 743.977,90 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 250.000,00 Euros. Desembolsado: 250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 250.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 250.000,00 Euros.

  • Otros Conceptos

    ADQUISICION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO DISPUR SL.

22/05/2009 Detalles del anuncio (233039) Datos registrales: T 41112 , F 131, S 8, H B 40372, I/A 30 (11.05.09).

  • Revocaciones

    APODERADO: CIRERA NOGUERAS JOSE ALBERTO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 13

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2019-46-08 07/03/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-212-08 07/11/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-90-08 14/05/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-10-08 16/01/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-80-08 28/04/2014 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-191-08 06/10/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-209-08 29/10/2010 Barcelona Descargar
BORME-B-2009-204-08 26/10/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-110-08 15/06/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-95-08 22/05/2009 Barcelona Descargar