FADERS SA
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 07/03/2019 | ALHOS CONCURSAL SLP |
Administrador concurs. |
| Cese: 07/03/2019 | PUIGVERT IBARS JOSE |
Representante administrador concurs. |
| Cese: 14/05/2015 | DISPUR SL |
Administrador único |
| Cese: 14/05/2015 | PLANES CORTS EULALIA |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 16/01/2015 | ALHOS CONCURSAL SLP |
Administrador concurs. |
| Nombramiento: 16/01/2015 | PUIGVERT IBARS JOSE |
Representante administrador concurs. |
| Cese: 28/04/2014 | JOVE ARRUEBO SUSANA CONCEPCION |
Apoderado |
| Cese: 22/05/2009 | CIRERA NOGUERAS JOSE ALBERTO |
Apoderado |
| Cese: 03/04/2009 | DISPUR SL |
Consejero |
| Cese: 03/04/2009 | DISPUR SL |
Presidente |
| Cese: 03/04/2009 | RISK 2002 SL |
Consejero |
| Cese: 03/04/2009 | RISK 2002 SL |
Vicepresidente |
| Cese: 03/04/2009 | ALTERNATIVA SERVICIOS RESIDENCIALES SL |
Consejero |
| Cese: 03/04/2009 | PLANES CORTS EULALIA |
Consejero |
| Cese: 03/04/2009 | PLANES CORTS EULALIA |
Secretario |
| Cese: 03/04/2009 | PLANES VILA JUAN |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 03/04/2009 | CIRERA NOGUERAS JOSE ALBERTO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 03/04/2009 | CIRERA NOGUERAS ANTONIO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 03/04/2009 | DISPUR SL |
Administrador único |
| Nombramiento: 03/04/2009 | PLANES CORTS EULALIA |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 25/03/2009 | JOVE ARRUEBO SUSANA CONCEPCION |
Apoderado |
| Nombramiento: 25/03/2009 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO |
Apoderado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por FADERS SA
07/03/2019 Detalles del anuncio (105645) Datos registrales: T 41112 , F 134, S 8, H B 40372, I/A 36 (28.02.19).
- Revocaciones
ADM.CONCURS.: ALHOS CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: PUIGVERT IBARS JOSE.
- Otros Conceptos
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 810/2014, AUTO FIRME DE FECHA 25/01/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
- Extinción
07/11/2016 Detalles del anuncio (446937) Datos registrales: T 41112 , F 133, S 8, H B 40372, I/A 35 (31.10.16).
- Otros Conceptos
JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 810/2014, AUTO FIRME DE FECHA 29/07/2016, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION.
14/05/2015 Detalles del anuncio (195516) Datos registrales: T 41112 , F 133, S 8, H B 40372, I/A 34 ( 7.05.15).
- Revocaciones
ADM.UNICO: DISPUR SL. REPR.143 RRM: PLANES CORTS EULALIA.
- Otros Conceptos
JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 810/2014, AUTO FIRME DE FECHA 28/01/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
- Disolución
Judicial.
16/01/2015 Detalles del anuncio (15545) Datos registrales: T 41112 , F 132, S 8, H B 40372, I/A 33 ( 8.01.15).
- Nombramientos
ADM.CONCURS.: ALHOS CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: PUIGVERT IBARS JOSE.
- Otros Conceptos
JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 810/2014, AUTO FIRME DE FECHA 30/10/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
28/04/2014 Detalles del anuncio (181129) Datos registrales: T 41112 , F 132, S 8, H B 40372, I/A 32 (16.04.14).
- Revocaciones
APODERADO: JOVE ARRUEBO SUSANA CONCEPCION.
06/10/2011 Detalles del anuncio (710961)
- Depósitos de cuentas anuales
(Agosto de 2011) Año: 2010
29/10/2010 Detalles del anuncio (924971)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2010) Año: 2009
26/10/2009 Detalles del anuncio (739298)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2009) Año: 2008
15/06/2009 Detalles del anuncio (266545) Datos registrales: T 41112 , F 131, S 8, H B 40372, I/A 31 ( 2.06.09).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 743.977,90 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros.
- Ampliación de Capital
Suscrito: 250.000,00 Euros. Desembolsado: 250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 250.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 250.000,00 Euros.
- Otros Conceptos
ADQUISICION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO DISPUR SL.
22/05/2009 Detalles del anuncio (233039) Datos registrales: T 41112 , F 131, S 8, H B 40372, I/A 30 (11.05.09).
- Revocaciones
APODERADO: CIRERA NOGUERAS JOSE ALBERTO.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 13
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2019-46-08 | 07/03/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2016-212-08 | 07/11/2016 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-90-08 | 14/05/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-10-08 | 16/01/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-80-08 | 28/04/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-B-2011-191-08 | 06/10/2011 | Barcelona | Descargar |
| BORME-B-2010-209-08 | 29/10/2010 | Barcelona | Descargar |
| BORME-B-2009-204-08 | 26/10/2009 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2009-110-08 | 15/06/2009 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2009-95-08 | 22/05/2009 | Barcelona | Descargar |