ESTAMPACIONES SOFEMA SLL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 18/01/2024 | EASO AUDITORES CONSULTORES SL |
Auditor |
| Cese: 22/04/2019 | LAHIDALGA ZALDUEGUI ALBERTO |
Consejero |
| Cese: 22/04/2019 | MENDAZONA ERQUIAGA JUAN-CARLOS |
Consejero |
| Cese: 22/04/2019 | DE LUIS TERUELO ADOLFO |
Consejero |
| Cese: 22/04/2019 | LAHIDALGA ZALDUEGUI ALBERTO |
Secretario |
| Cese: 22/04/2019 | MENDAZONA ERQUIAGA JUAN-CARLOS |
Presidente |
| Cese: 22/04/2019 | MENDAZONA ERQUIAGA JUAN- CARLOS |
Apoderado solidario |
| Cese: 22/04/2019 | LAHIDALGA ZALDUEGUI ALBERTO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 22/04/2019 | LOPETEGUI GALARRAGA JON- ANDER |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 22/04/2019 | LOPETEGUI GALARRAGA AITOR |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 22/04/2019 | LOPETEGUI GALARRAGA IGNACIO (IÑAKI) |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 22/04/2019 | LOPETEGUI GALARRAGA JOSE-MIGUEL |
Administrador solidario |
| Cese: 07/06/2013 | CORTAZAR BILBAO JESUS-MARIA |
Consejero |
| Cese: 07/06/2013 | CORTAZAR BILBAO JESUS-MARIA |
Secretario |
| Nombramiento: 07/06/2013 | LAHIDALGA ZALDUEGUI ALBERTO |
Secretario |
| Nombramiento: 04/04/2012 | LAHIDALGA ZALDUEGUI ALBERTO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 04/04/2012 | MENDAZONA ERQUIAGA JUAN-CARLOS |
Apoderado solidario |
| Cese: 27/03/2012 | ASUA CELAYETA MARIA-ARANZAZU |
Consejero |
| Cese: 27/03/2012 | CORTAZAR BILBAO JESUS- MARIA |
Apoderado |
| Cese: 27/03/2012 | CORTAZAR BILBAO JESUS-MARIA |
Apoderado |
| Cese: 19/11/2010 | ASUA CELAYETA MARIA-ARANZAZU |
Consejero delegado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ESTAMPACIONES SOFEMA SLL
16/02/2024 Detalles del anuncio (82943) Datos registrales: T 1533 , F 109, S 8, H SS 10618, I/A 19 ( 6.02.24).
- Otros Conceptos
SUBSANACION de la Inscripción 17ª de cambio de Domicilio Social, al objeto de hacer constar que el DOMICILIO CORRECTO al que se traslada, es BERGARA, HARGIN KALEA, Nº2, PABELLON G1, modificando en consecuencia, el ARTICULO 3º de los Estatutos Sociales.-
18/01/2024 Detalles del anuncio (28364) Datos registrales: T 1533 , F 109, S 8, H SS 10618, I/A 18 ( 9.01.24).
- Nombramientos
Auditor: EASO AUDITORES CONSULTORES SL.
13/11/2023 Detalles del anuncio (478819) Datos registrales: T 1533 , F 109, S 8, H SS 10618, I/A 17 (31.10.23).
- Cambio de domicilio social
POLIG INDUSTRIAL LARRAMENDI, ERREMENTARI KALEA Nº (BERGARA).
22/04/2019 Detalles del anuncio (174491) Datos registrales: T 1533 , F 108, S 8, H SS 10618, I/A 16 (26.03.19).
- Declaración de unipersonalidad. Socio Único.
ZUHAITZMETAL SL.
- Ceses/Dimisiones
Consejero: LAHIDALGA ZALDUEGUI ALBERTO;MENDAZONA ERQUIAGA JUAN-CARLOS;DE LUIS TERUELO ADOLFO. Secretario: LAHIDALGA ZALDUEGUI ALBERTO. Presidente: MENDAZONA ERQUIAGA JUAN-CARLOS.
- Revocaciones
Apo.Sol.: MENDAZONA ERQUIAGA JUAN- CARLOS;LAHIDALGA ZALDUEGUI ALBERTO.
- Nombramientos
Adm. Solid.: LOPETEGUI GALARRAGA JON- ANDER;LOPETEGUI GALARRAGA AITOR;LOPETEGUI GALARRAGA IGNACIO (IÑAKI);LOPETEGUI GALARRAGA JOSE-MIGUEL.
- Otros Conceptos
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios.
29/03/2019 Detalles del anuncio (142275) Datos registrales: T 1533 , F 101, S 8, H SS 10618, I/A 15 (15.03.19).
- Modificaciones Estatutarias
La sociedad ESTAMPACIONES SOFEMA SLL pierde el carácter laboral pasándose a denominar ESTAMPACIONES SOFEMA SL.
- Otros Conceptos
MODIFICACION Y REFUNDICION DE ESTATUTOS SOCIALES como consecuencia de PERDIDA DEL CARACTER LABORAL DE ESTAMPACIONES SOFEMA, S.L..
11/10/2018 Detalles del anuncio (409517) Datos registrales: T 1533 , F 101, S 8, H SS 10618, I/A 14 ( 2.10.18).
- Cambio de objeto social
Fabricación de accesorios metálicos, estampados, embutición y otros.
20/11/2014 Detalles del anuncio (473300) Datos registrales: T 1533 , F 100, S 8, H SS 10618, I/A 13 (12.11.14).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 18.396,98 Euros. Resultante Suscrito: 41.704,23 Euros.
07/06/2013 Detalles del anuncio (261806) Datos registrales: T 1533 , F 100, S 8, H SS 10618, I/A 12 (29.05.13).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: CORTAZAR BILBAO JESUS-MARIA. Secretario: CORTAZAR BILBAO JESUS-MARIA.
- Nombramientos
Secretario: LAHIDALGA ZALDUEGUI ALBERTO.
04/04/2012 Detalles del anuncio (154347) Datos registrales: T 1533 , F 100, S 8, H SS 10618, I/A 11 (26.03.12).
- Nombramientos
Apo.Sol.: LAHIDALGA ZALDUEGUI ALBERTO;MENDAZONA ERQUIAGA JUAN-CARLOS.
27/03/2012 Detalles del anuncio (141075) Datos registrales: T 1533 , F 99, S 8, H SS 10618, I/A 10 (16.03.12).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: ASUA CELAYETA MARIA-ARANZAZU.
- Revocaciones
Apoderado: CORTAZAR BILBAO JESUS- MARIA;CORTAZAR BILBAO JESUS-MARIA.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 15
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2024-34-20 | 16/02/2024 | Gipuzkoa | Descargar |
| BORME-A-2024-13-20 | 18/01/2024 | Gipuzkoa | Descargar |
| BORME-A-2023-215-20 | 13/11/2023 | Gipuzkoa | Descargar |
| BORME-A-2019-76-20 | 22/04/2019 | Gipuzkoa | Descargar |
| BORME-A-2019-62-20 | 29/03/2019 | Gipuzkoa | Descargar |
| BORME-A-2018-197-20 | 11/10/2018 | Gipuzkoa | Descargar |
| BORME-A-2014-222-20 | 20/11/2014 | Gipuzkoa | Descargar |
| BORME-A-2013-106-20 | 07/06/2013 | Gipuzkoa | Descargar |
| BORME-A-2012-66-20 | 04/04/2012 | Gipuzkoa | Descargar |
| BORME-A-2012-60-20 | 27/03/2012 | Gipuzkoa | Descargar |