CODERE INTERACTIVA SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 25/11/2021 | JIMENEZ MARQUEZ DAVID |
Secretario no consejero |
| Cese: 25/11/2021 | MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO |
Consejero |
| Cese: 25/11/2021 | ORS VILLAREJO FERNANDO |
Consejero |
| Cese: 25/11/2021 | ROMERO RODRIGUEZ JOSE RAMON |
Consejero |
| Cese: 25/11/2021 | MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO |
Presidente |
| Nombramiento: 25/11/2021 | MARTINEZ JIMENEZ OSCAR |
Liquidador |
| Cese: 26/07/2017 | LOPEZ ENRIQUEZ CHILLON RAFAEL |
Apoderado solidario |
| Cese: 02/07/2012 | CATALA POLO RAFAEL |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 02/07/2012 | JIMENEZ MARQUEZ DAVID |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 09/05/2011 | PINTO MARABOTTO JOSE LUIS |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 09/05/2011 | PINTO-MARABOTTO RUIZ JOSE LUIS |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 09/05/2011 | LAZARO GOGORZA ANA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 09/05/2011 | PARRA CEBEIRA JUAN IGNACIO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 09/05/2011 | LOMAS SAMPEDRO FRANCISCO-JAVIER |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 09/05/2011 | JIMENEZ ALFARO ESPERON JOSE ANTONIO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 09/05/2011 | SOMALO HERNANDEZ LUCIA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 21/03/2011 | LOPEZ ENRIQUEZ CHILLON RAFAEL |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 21/03/2011 | PEREZ PEREZ JUAN MIGUEL |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 21/03/2011 | GONZALEZ REDONDO ANGEL |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 21/03/2011 | TABERNER BENAGES FRANCISCO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 18/03/2011 | BUJIDOS CASADO MARIA |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 18/03/2011 | MARTIN DE PRADO JUAN PABLO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 18/03/2011 | ELIAS CREMADES BEGOÑA |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 31/07/2009 | ORS VILLAREJO FERNANDO |
Apoderado |
| Nombramiento: 31/07/2009 | ORS VILLAREJO FERNANDO |
Director general |
| Nombramiento: 06/07/2009 | MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO |
Consejero |
| Nombramiento: 06/07/2009 | ORS VILLAREJO FERNANDO |
Consejero |
| Nombramiento: 06/07/2009 | ROMERO RODRIGUEZ JOSE RAMON |
Consejero |
| Nombramiento: 06/07/2009 | MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO |
Presidente |
| Nombramiento: 06/07/2009 | CATALA POLO RAFAEL |
Secretario no consejero |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por CODERE INTERACTIVA SL
25/11/2021 Detalles del anuncio (512430) Datos registrales: T 26814 , F 204, S 8, H M 483182, I/A 10 (18.11.21).
- Ceses/Dimisiones
SecreNoConsj: JIMENEZ MARQUEZ DAVID. Consejero: MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO;ORS VILLAREJO FERNANDO;ROMERO RODRIGUEZ JOSE RAMON. Presidente: MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO.
- Nombramientos
Liquidador: MARTINEZ JIMENEZ OSCAR.
- Disolución
Voluntaria.
- Extinción
26/07/2017 Detalles del anuncio (307301) Datos registrales: T 26814 , F 204, S 8, H M 483182, I/A 9 (19.07.17).
- Revocaciones
Apo.Sol.: LOPEZ ENRIQUEZ CHILLON RAFAEL.
23/10/2015 Detalles del anuncio (427504) Datos registrales: T 26814 , F 201, S 8, H M 483182, I/A 8 (16.10.15).
- Modificaciones Estatutarias
MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y APROBACION DEL NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS MISMOS..
02/07/2012 Detalles del anuncio (277893) Datos registrales: T 26814 , F 201, S 8, H M 483182, I/A 7 (20.06.12).
- Ceses/Dimisiones
SecreNoConsj: CATALA POLO RAFAEL.
- Nombramientos
SecreNoConsj: JIMENEZ MARQUEZ DAVID.
10/08/2011 Detalles del anuncio (274066)
- Depósitos de cuentas anuales
(Julio de 2011) Año: 2010
09/05/2011 Detalles del anuncio (197666) Datos registrales: T 26814 , F 200, S 8, H M 483182, I/A 6 (26.04.11).
- Nombramientos
Apo.Sol.: PINTO MARABOTTO JOSE LUIS;PINTO-MARABOTTO RUIZ JOSE LUIS;LAZARO GOGORZA ANA;PARRA CEBEIRA JUAN IGNACIO;LOMAS SAMPEDRO FRANCISCO-JAVIER;JIMENEZ ALFARO ESPERON JOSE ANTONIO;SOMALO HERNANDEZ LUCIA.
21/03/2011 Detalles del anuncio (126412) Datos registrales: T 26814 , F 200, S 8, H M 483182, I/A 5 ( 9.03.11).
- Nombramientos
Apo.Sol.: LOPEZ ENRIQUEZ CHILLON RAFAEL;PEREZ PEREZ JUAN MIGUEL;GONZALEZ REDONDO ANGEL;TABERNER BENAGES FRANCISCO.
18/03/2011 Detalles del anuncio (124363) Datos registrales: T 26814 , F 199, S 8, H M 483182, I/A 4 ( 9.03.11).
- Nombramientos
Apo.Man.Soli: BUJIDOS CASADO MARIA;MARTIN DE PRADO JUAN PABLO;ELIAS CREMADES BEGOÑA.
22/10/2010 Detalles del anuncio (877044)
- Depósitos de cuentas anuales
(Octubre de 2010) Año: 2009
31/07/2009 Detalles del anuncio (338792) Datos registrales: T 26814 , F 198, S 8, H M 483182, I/A 3 (18.07.09).
- Nombramientos
Apoderado: ORS VILLAREJO FERNANDO. Dir. General: ORS VILLAREJO FERNANDO.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2021-226-28 | 25/11/2021 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-141-28 | 26/07/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-203-28 | 23/10/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-124-28 | 02/07/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2011-152-28 | 10/08/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-87-28 | 09/05/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-55-28 | 21/03/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-54-28 | 18/03/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2010-204-28 | 22/10/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2009-144-28 | 31/07/2009 | Madrid | Descargar |