CODERE INTERACTIVA SL

Extinta

AVDA DE BRUSELAS 26 - BAJO A (ALCOBENDAS).
 Alcobendas, Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 25/11/2021

JIMENEZ MARQUEZ DAVID

Secretario no consejero
Cese: 25/11/2021

MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO

Consejero
Cese: 25/11/2021

ORS VILLAREJO FERNANDO

Consejero
Cese: 25/11/2021

ROMERO RODRIGUEZ JOSE RAMON

Consejero
Cese: 25/11/2021

MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO

Presidente
Nombramiento: 25/11/2021

MARTINEZ JIMENEZ OSCAR

Liquidador
Cese: 26/07/2017

LOPEZ ENRIQUEZ CHILLON RAFAEL

Apoderado solidario
Cese: 02/07/2012

CATALA POLO RAFAEL

Secretario no consejero
Nombramiento: 02/07/2012

JIMENEZ MARQUEZ DAVID

Secretario no consejero
Nombramiento: 09/05/2011

PINTO MARABOTTO JOSE LUIS

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/05/2011

PINTO-MARABOTTO RUIZ JOSE LUIS

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/05/2011

LAZARO GOGORZA ANA

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/05/2011

PARRA CEBEIRA JUAN IGNACIO

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/05/2011

LOMAS SAMPEDRO FRANCISCO-JAVIER

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/05/2011

JIMENEZ ALFARO ESPERON JOSE ANTONIO

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/05/2011

SOMALO HERNANDEZ LUCIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 21/03/2011

LOPEZ ENRIQUEZ CHILLON RAFAEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 21/03/2011

PEREZ PEREZ JUAN MIGUEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 21/03/2011

GONZALEZ REDONDO ANGEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 21/03/2011

TABERNER BENAGES FRANCISCO

Apoderado solidario
Nombramiento: 18/03/2011

BUJIDOS CASADO MARIA

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/03/2011

MARTIN DE PRADO JUAN PABLO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/03/2011

ELIAS CREMADES BEGOÑA

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 31/07/2009

ORS VILLAREJO FERNANDO

Apoderado
Nombramiento: 31/07/2009

ORS VILLAREJO FERNANDO

Director general
Nombramiento: 06/07/2009

MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 06/07/2009

ORS VILLAREJO FERNANDO

Consejero
Nombramiento: 06/07/2009

ROMERO RODRIGUEZ JOSE RAMON

Consejero
Nombramiento: 06/07/2009

MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO

Presidente
Nombramiento: 06/07/2009

CATALA POLO RAFAEL

Secretario no consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por CODERE INTERACTIVA SL

25/11/2021 Detalles del anuncio (512430) Datos registrales: T 26814 , F 204, S 8, H M 483182, I/A 10 (18.11.21).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: JIMENEZ MARQUEZ DAVID. Consejero: MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO;ORS VILLAREJO FERNANDO;ROMERO RODRIGUEZ JOSE RAMON. Presidente: MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO.

  • Nombramientos

    Liquidador: MARTINEZ JIMENEZ OSCAR.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

26/07/2017 Detalles del anuncio (307301) Datos registrales: T 26814 , F 204, S 8, H M 483182, I/A 9 (19.07.17).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: LOPEZ ENRIQUEZ CHILLON RAFAEL.

23/10/2015 Detalles del anuncio (427504) Datos registrales: T 26814 , F 201, S 8, H M 483182, I/A 8 (16.10.15).

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y APROBACION DEL NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS MISMOS..

02/07/2012 Detalles del anuncio (277893) Datos registrales: T 26814 , F 201, S 8, H M 483182, I/A 7 (20.06.12).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: CATALA POLO RAFAEL.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: JIMENEZ MARQUEZ DAVID.

10/08/2011 Detalles del anuncio (274066)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2011) Año: 2010

09/05/2011 Detalles del anuncio (197666) Datos registrales: T 26814 , F 200, S 8, H M 483182, I/A 6 (26.04.11).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: PINTO MARABOTTO JOSE LUIS;PINTO-MARABOTTO RUIZ JOSE LUIS;LAZARO GOGORZA ANA;PARRA CEBEIRA JUAN IGNACIO;LOMAS SAMPEDRO FRANCISCO-JAVIER;JIMENEZ ALFARO ESPERON JOSE ANTONIO;SOMALO HERNANDEZ LUCIA.

21/03/2011 Detalles del anuncio (126412) Datos registrales: T 26814 , F 200, S 8, H M 483182, I/A 5 ( 9.03.11).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: LOPEZ ENRIQUEZ CHILLON RAFAEL;PEREZ PEREZ JUAN MIGUEL;GONZALEZ REDONDO ANGEL;TABERNER BENAGES FRANCISCO.

18/03/2011 Detalles del anuncio (124363) Datos registrales: T 26814 , F 199, S 8, H M 483182, I/A 4 ( 9.03.11).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: BUJIDOS CASADO MARIA;MARTIN DE PRADO JUAN PABLO;ELIAS CREMADES BEGOÑA.

22/10/2010 Detalles del anuncio (877044)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2010) Año: 2009

31/07/2009 Detalles del anuncio (338792) Datos registrales: T 26814 , F 198, S 8, H M 483182, I/A 3 (18.07.09).

  • Nombramientos

    Apoderado: ORS VILLAREJO FERNANDO. Dir. General: ORS VILLAREJO FERNANDO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2021-226-28 25/11/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2017-141-28 26/07/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2015-203-28 23/10/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2012-124-28 02/07/2012 Madrid Descargar
BORME-B-2011-152-28 10/08/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-87-28 09/05/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-55-28 21/03/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-54-28 18/03/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-204-28 22/10/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2009-144-28 31/07/2009 Madrid Descargar