CANTABRIAN INTEGRATED LOGISTIC SERVICES SA

Extinta

C/ ALCALA 65 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 25/02/2020

AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/02/2020

AGUIRRE OLORIZ IGNACIO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/02/2020

GONZALEZ TOJO ANDRES

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/02/2020

DIAZ LARRIETA KOLDOBIKA

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/02/2020

HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/02/2020

GOMEZ DE SALAZAR DE VIANA BELEN

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/02/2020

SALDAÑA SOLERA SERGIO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/02/2020

MARTIN FRANCO JORGE

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 11/12/2019

GARCIA-MIÑAUR CAREAGA GONZALO

Apoderado
Nombramiento: 12/07/2019

BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL

Administrador único
Nombramiento: 12/07/2019

LOPEZ-DORIGA ESCALANTE JUAN

Representante
Cese: 02/11/2017

BERNAL CATALAN JORGE

Apoderado
Cese: 21/04/2017

FERNANDEZ BILBAO ANA

Apoderado
Nombramiento: 21/04/2017

SALDAÑA SOLERA SERGIO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 19/12/2016

RUBIO VILAR RICARDO

Representante
Nombramiento: 19/12/2016

LOPEZ-DORIGA ESCALANTE JUAN

Representante
Cese: 04/03/2016

MARTINEZ PEREZ BLANCA

Apoderado
Cese: 27/07/2015

DOPICO RUIZ ARANZAZU

Apoderado
Nombramiento: 27/07/2015

DIAZ LARRIETA KOLDOBIKA

Apoderado
Nombramiento: 27/07/2015

HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL

Apoderado
Nombramiento: 23/06/2014

BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL

Administrador único
Nombramiento: 23/06/2014

RUBIO VILAR RICARDO

Representante
Cese: 19/03/2014

PORTILLO MANERO ANDRES

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por CANTABRIAN INTEGRATED LOGISTIC SERVICES SA

12/01/2021 Detalles del anuncio (11208) Datos registrales: T 31717 , F 138, S 8, H M 283038, I/A 46 ( 4.01.21).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

25/02/2020 Detalles del anuncio (86695) Datos registrales: T 31717 , F 137, S 8, H M 283038, I/A 45 (18.02.20).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;GONZALEZ TOJO ANDRES;DIAZ LARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANA BELEN;SALDAÑA SOLERA SERGIO;MARTIN FRANCO JORGE.

11/12/2019 Detalles del anuncio (507965) Datos registrales: T 31717 , F 137, S 8, H M 283038, I/A 44 ( 2.12.19).

  • Revocaciones

    Apoderado: GARCIA-MIÑAUR CAREAGA GONZALO.

12/07/2019 Detalles del anuncio (301001) Datos registrales: T 31717 , F 137, S 8, H M 283038, I/A 43 ( 5.07.19).

  • Reelecciones

    Adm. Unico: BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL. Representan: LOPEZ-DORIGA ESCALANTE JUAN.

02/11/2017 Detalles del anuncio (431634) Datos registrales: T 31717 , F 137, S 8, H M 283038, I/A 42 (24.10.17).

  • Revocaciones

    Apoderado: BERNAL CATALAN JORGE.

21/04/2017 Detalles del anuncio (173729) Datos registrales: T 31717 , F 136, S 8, H M 283038, I/A 41 (11.04.17).

  • Revocaciones

    Apoderado: FERNANDEZ BILBAO ANA.

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: SALDAÑA SOLERA SERGIO.

13/01/2017 Detalles del anuncio (16433) Datos registrales: T 31717 , F 136, S 8, H M 283038, I/A 40 ( 2.01.17).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL.

19/12/2016 Detalles del anuncio (511291) Datos registrales: T 31717 , F 136, S 8, H M 283038, I/A 39 ( 9.12.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: RUBIO VILAR RICARDO.

  • Nombramientos

    Representan: LOPEZ-DORIGA ESCALANTE JUAN.

04/03/2016 Detalles del anuncio (104074) Datos registrales: T 31717 , F 136, S 8, H M 283038, I/A 38 (25.02.16).

  • Revocaciones

    Apoderado: MARTINEZ PEREZ BLANCA.

27/07/2015 Detalles del anuncio (309137) Datos registrales: T 31717 , F 135, S 8, H M 283038, I/A 37 (17.07.15).

  • Revocaciones

    Apoderado: DOPICO RUIZ ARANZAZU.

  • Nombramientos

    Apoderado: DIAZ LARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 26

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2021-6-28 12/01/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-38-28 25/02/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-236-28 11/12/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-132-28 12/07/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2017-209-28 02/11/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-76-28 21/04/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-9-28 13/01/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-239-28 19/12/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-44-28 04/03/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-140-28 27/07/2015 Madrid Descargar