ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL

Cambio de denominación social

C/ JULIAN CAMARILLO 4 C (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 27/03/2018

LLADO IGLESIAS MIGUEL

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2018

DIEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2018

MANZANOS CASELLAS NURIA

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2018

ORO SERNA JEZAEL

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2018

SANCHEZ-BEATO DIAZ-MARTA MARIA DEL CARMEN

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2018

MAYO GONZALEZ ALBERTO

Apoderado
Nombramiento: 21/03/2018

RODRIGUEZ SOLER FRANCISCO JAVIER

Apoderado solidario
Nombramiento: 21/03/2018

FERRIS MONERA JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/10/2017

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 29/09/2017

GOMEZ ARENAS ANDRES IVAN

Apoderado
Cese: 24/08/2017

ANDRES GONZALEZ SALVADOR

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 24/08/2017

EJEDA MENENDEZ DAVID

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 24/08/2017

GARCIA MATIACCI MARIA DEL MAR

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 24/08/2017

GONZALO MATAMALA CARLOS

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 24/08/2017

VIDAL ARAGON DE OLIVES AGUSTIN

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 24/08/2017

LOPEZ ALVAREZ JOSE CARLOS

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 24/08/2017

ORTUETA MONFORT JUAN MAXIMILIANO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 24/08/2017

VILLARES CASADO MANUEL

Apoderado
Cese: 24/08/2017

FERNANDEZ DELGADO PABLO

Apoderado
Cese: 24/08/2017

GIL DOBLADO MIGUEL ANGEL

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 24/08/2017

RODRIGUEZ BASTERRECHE IRENE

Apoderado
Nombramiento: 15/03/2017

ORTUETA MONFORT JUAN MAXIMILIANO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 15/03/2017

EGEA YETANO PEDRO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 15/03/2017

FERNANDEZ MANRIQUE ANA

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 15/03/2017

VIDAL ARAGON DE OLIVES AGUSTIN

Consejero
Cese: 15/03/2017

LOPEZ ALVAREZ JOSE CARLOS

Consejero
Cese: 15/03/2017

VIDAL ARAGON DE OLIVES AGUSTIN

Presidente
Nombramiento: 15/03/2017

EGEA YETANO PEDRO

Consejero
Nombramiento: 15/03/2017

FERNANDEZ MANRIQUE ANA

Consejero
Nombramiento: 15/03/2017

ORTUETA MONFORT JUAN MAXIMILIANO

Presidente
Cese: 20/12/2016

LAQUIDAIN HERGUETA ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 27/10/2016

SANCHEZ MARTINEZ GUILLERMO

Apoderado
Nombramiento: 26/10/2016

LORENZO HERNANDEZ JOSE LUIS

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL

04/07/2018 Detalles del anuncio (279559) Datos registrales: T 34880 , F 85, S 8, H M 122963, I/A 199 (27.06.18).

  • Cambio de denominación social

    DIVARIAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL.

11/06/2018 Detalles del anuncio (244438) Datos registrales: T 34880 , F 84, S 8, H M 122963, I/A 198 ( 4.06.18).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 500.004,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.167.717,40 Euros.

16/04/2018 Detalles del anuncio (166534) Datos registrales: T 34880 , F 84, S 8, H M 122963, I/A 197 ( 6.04.18).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    ANIDA GRUPO INMOBILIARIO SL.

27/03/2018 Detalles del anuncio (140043) Datos registrales: T 34880 , F 83, S 8, H M 122963, I/A 196 (20.03.18).

  • Nombramientos

    Apoderado: LLADO IGLESIAS MIGUEL;DIEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES;MANZANOS CASELLAS NURIA;ORO SERNA JEZAEL;SANCHEZ-BEATO DIAZ-MARTA MARIA DEL CARMEN;MAYO GONZALEZ ALBERTO.

21/03/2018 Detalles del anuncio (131107) Datos registrales: T 34880 , F 82, S 8, H M 122963, I/A 195 (14.03.18).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: RODRIGUEZ SOLER FRANCISCO JAVIER;FERRIS MONERA JOSE.

09/10/2017 Detalles del anuncio (398152) Datos registrales: T 34880 , F 82, S 8, H M 122963, I/A 194 (29.09.17).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

29/09/2017 Detalles del anuncio (388118) Datos registrales: T 34880 , F 82, S 8, H M 122963, I/A 193 (21.09.17).

  • Revocaciones

    Apoderado: GOMEZ ARENAS ANDRES IVAN.

24/08/2017 Detalles del anuncio (347305) Datos registrales: T 34880 , F 81, S 8, H M 122963, I/A 192 (16.08.17).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: ANDRES GONZALEZ SALVADOR;EJEDA MENENDEZ DAVID;GARCIA MATIACCI MARIA DEL MAR;GONZALO MATAMALA CARLOS;VIDAL ARAGON DE OLIVES AGUSTIN;LOPEZ ALVAREZ JOSE CARLOS;ORTUETA MONFORT JUAN MAXIMILIANO. Apoderado: VILLARES CASADO MANUEL;FERNANDEZ DELGADO PABLO. Apo.Man.Soli: GIL DOBLADO MIGUEL ANGEL. Apoderado: RODRIGUEZ BASTERRECHE IRENE.

15/03/2017 Detalles del anuncio (119656) Datos registrales: T 34880 , F 78, S 8, H M 122963, I/A 191 ( 8.03.17).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: ORTUETA MONFORT JUAN MAXIMILIANO;EGEA YETANO PEDRO;FERNANDEZ MANRIQUE ANA.

15/03/2017 Detalles del anuncio (119655) Datos registrales: T 34880 , F 77, S 8, H M 122963, I/A 190 ( 8.03.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: VIDAL ARAGON DE OLIVES AGUSTIN;LOPEZ ALVAREZ JOSE CARLOS. Presidente: VIDAL ARAGON DE OLIVES AGUSTIN.

  • Nombramientos

    Consejero: EGEA YETANO PEDRO;FERNANDEZ MANRIQUE ANA. Presidente: ORTUETA MONFORT JUAN MAXIMILIANO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 126

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2018-127-28 04/07/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-110-28 11/06/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-73-28 16/04/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-61-28 27/03/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-57-28 21/03/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-193-28 09/10/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-187-28 29/09/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-161-28 24/08/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-52-28 15/03/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-52-28 15/03/2017 Madrid Descargar