ANDASOL-3 CENTRAL TERMOSOLAR TRES SL

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 22/02/2016

SANCHEZ SOBRINO OSCAR

Apoderado
Nombramiento: 22/02/2016

MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL

Apoderado
Nombramiento: 22/02/2016

BERMUDEZ PEREZ TOMAS

Apoderado
Nombramiento: 22/02/2016

ABRIL MARTIN MARCIAL

Apoderado
Nombramiento: 22/02/2016

ESPADA MONZON JOSE ENRIQUE

Apoderado
Nombramiento: 22/02/2016

LOZANO PUEYO EPIFANIO

Apoderado
Nombramiento: 22/02/2016

AGUDO SAIZ JULIO

Apoderado
Cese: 16/01/2015

JIMENEZ SERRANO RAMON

Representante
Nombramiento: 16/01/2015

REIN ROJO LUIS

Representante
Nombramiento: 26/03/2013

COBRA SISTEMAS Y REDES SA

Administrador único
Cese: 29/10/2012

PEREZ LORENZO JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 16/07/2012

AGUDO SAIZ JULIO

Apoderado
Cese: 03/07/2012

GOMEZ ZAMORA ANTONIO

Apoderado
Cese: 03/07/2012

MUÑOZ GONZALEZ ALBO JUAN MANUEL

Apoderado
Cese: 03/07/2012

GOMEZ ZAMORA ANTONIO

Apoderado
Cese: 02/07/2012

GOMEZ ZAMORA ANTONIO

Representante
Nombramiento: 02/07/2012

JIMENEZ SERRANO RAMON

Representante
Cese: 21/12/2010

LLORENTE GOMEZ EUGENIO BARTOLOME

Representante
Nombramiento: 21/12/2010

GOMEZ ZAMORA ANTONIO

Representante
Nombramiento: 18/06/2009

GOMEZ ZAMORA ANTONIO

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ANDASOL-3 CENTRAL TERMOSOLAR TRES SL

10/11/2016 Detalles del anuncio (450277) Datos registrales: T 35236 , F 1, S 8, H M 432992, I/A 15 (24.10.16).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

22/02/2016 Detalles del anuncio (78628) Datos registrales: T 24098 , F 203, S 8, H M 432992, I/A 14 (12.02.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: SANCHEZ SOBRINO OSCAR;MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL;BERMUDEZ PEREZ TOMAS;ABRIL MARTIN MARCIAL;ESPADA MONZON JOSE ENRIQUE.

22/02/2016 Detalles del anuncio (78627) Datos registrales: T 24098 , F 202, S 8, H M 432992, I/A 13 (12.02.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: LOZANO PUEYO EPIFANIO;AGUDO SAIZ JULIO.

16/01/2015 Detalles del anuncio (16658) Datos registrales: T 24098 , F 202, S 8, H M 432992, I/A 12 ( 8.01.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON.

  • Nombramientos

    Representan: REIN ROJO LUIS.

26/03/2013 Detalles del anuncio (145896) Datos registrales: T 24098 , F 201, S 8, H M 432992, I/A 11 (11.03.13).

  • Reelecciones

    Adm. Unico: COBRA SISTEMAS Y REDES SA.

29/10/2012 Detalles del anuncio (441824) Datos registrales: T 24098 , F 201, S 8, H M 432992, I/A 10 (18.10.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: PEREZ LORENZO JAVIER.

16/07/2012 Detalles del anuncio (298902) Datos registrales: T 24098 , F 200, S 8, H M 432992, I/A 9 ( 4.07.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: AGUDO SAIZ JULIO.

03/07/2012 Detalles del anuncio (280330) Datos registrales: T 24098 , F 200, S 8, H M 432992, I/A 8 (22.06.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: GOMEZ ZAMORA ANTONIO;MUÑOZ GONZALEZ ALBO JUAN MANUEL;GOMEZ ZAMORA ANTONIO.

02/07/2012 Detalles del anuncio (278242) Datos registrales: T 24098 , F 200, S 8, H M 432992, I/A 7 (21.06.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: GOMEZ ZAMORA ANTONIO.

  • Nombramientos

    Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON.

10/06/2011 Detalles del anuncio (171600)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Mayo de 2011) Año: 2010

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 14

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2016-214-28 10/11/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-35-28 22/02/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-35-28 22/02/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-10-28 16/01/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2013-58-28 26/03/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-208-28 29/10/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-134-28 16/07/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-125-28 03/07/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-124-28 02/07/2012 Madrid Descargar
BORME-B-2011-111-28 10/06/2011 Madrid Descargar