ZAPHIR LOGISTIC PROPERTIES SA

Extinta

C/ GENERAL LACY 23 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com ne vend pas de données d'entreprise, ne propose ses informations qu'au public.

Si vous souhaitez le mettre à jour ou le modifier inscrivez-vous gratuitement

Derniers mouvements

Date
Nom
Nombramiento: 03/07/2018

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 09/05/2017

AGUIRRE NEWMAN MADRID SA

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 09/05/2017

RAMIREZ DE HARO AGUIRRE FERNANDO

Apoderado mancomunado
Cese: 09/05/2017

GUTIERREZ BRU JOSE MARIA

Apoderado mancomunado
Cese: 09/05/2017

ALVEZ OVIEDO MIRIAM

Apoderado solidario
Cese: 10/02/2017

CERCADILLO CUERDA CARLOS

Representante
Cese: 10/02/2017

FERNANDEZ PARADELA BELEN

Representante
Cese: 10/02/2017

FERNANDEZ PARADELA SUSANA

Representante
Cese: 10/02/2017

CANSECO GARCIA-PITA TERESA

Vicesecretario no consejero
Cese: 10/02/2017

BARON BASTARRECHE ALFONSO

Secretario no consejero
Cese: 10/02/2017

AGUIRRE GIL DE BIEDMA SANTIAGO

Presidente
Cese: 10/02/2017

LAFITA TORRES ALFREDO

Consejero
Cese: 10/02/2017

EXINA SL

Consejero
Cese: 10/02/2017

CERCUPENTA INTERNATIONAL BV

Consejero
Cese: 10/02/2017

CERCADILLO CUERDA NURIA

Consejero
Cese: 10/02/2017

INVERSIONES SUBEL SL

Consejero
Cese: 10/02/2017

INVERSIONES CALDE SL

Consejero
Cese: 10/02/2017

INVERSIONES CLAUDIA SL

Consejero
Cese: 10/02/2017

ISRAEL ABECASIS MOISES

Consejero
Cese: 10/02/2017

AGUIRRE GIL DE BIEDMA SANTIAGO

Consejero
Cese: 10/02/2017

CAIXA CATALUNYA GESTIO SGIIC SA

Consejero
Cese: 10/02/2017

PROMOCIONES AL DESARROLLO BUMARI SOCIEDAD LIMITADA

Consejero
Cese: 10/02/2017

ITURZAETA GOENAGA MIREN NEKANE

Consejero
Cese: 10/02/2017

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO

Consejero
Cese: 10/02/2017

MARTI RABASSA XAVIER

Representante
Cese: 10/02/2017

RUBIO GARCIA CRISTINA

Representante
Cese: 10/02/2017

MOLINER ROBREDO FERNANDO

Representante
Cese: 10/02/2017

DE MUGUIRO MIRANDA JAVIER

Representante
Cese: 10/02/2017

LANDROVE BERMUDEZ JAVIER

Representante
Nombramiento: 10/02/2017

AMURA MANAGEMENT PARTNERS SL

Liquidador
Nombramiento: 10/02/2017

COBO BUXENS ALVARO

Representante
Cese: 24/01/2017

LARUMBE ARBILLA MIREN IOSUNE

Representante
Nombramiento: 24/01/2017

MOLINER ROBREDO FERNANDO

Representante
Nombramiento: 03/01/2017

ALVEZ TOLEDO MIRIAM

Apoderado
Cese: 29/11/2016

CORDERO GOMEZ RAQUEL

Representante
Nombramiento: 29/11/2016

RUBIO GARCIA CRISTINA

Representante
Cese: 03/06/2016

CORDERO GOMEZ RAQUEL

Representante
Cese: 03/06/2016

INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA

Vicepresidente
Cese: 03/06/2016

INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA

Consejero
Nombramiento: 03/06/2016

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO

Consejero
Nombramiento: 03/06/2016

CORDERO GOMEZ RAQUEL

Representante
Nombramiento: 26/05/2016

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 03/05/2016

VICUÑA CASTREJON JOSE MARIA

Representante
Nombramiento: 03/05/2016

LARUMBE ARBILLA MIREN IOSUNE

Representante
Nombramiento: 03/05/2016

PROMOCIONES AL DESARROLLO BUMARI SL

Consejero
Nombramiento: 13/04/2016

ITURZAETA GOENAGA MIREN NEKANE

Consejero

Registres d'entreprises connexes

Actes commerciaux publiés dans l'édition numérique du registre du commerce liés ou enregistrés par ZAPHIR LOGISTIC PROPERTIES SA

26/12/2018 Détails de l'annonce (517570) Données du registre: T 35221 , F 51, S 8, H M 425601, I/A 66 (18.12.18).

  • Extinción

03/07/2018 Détails de l'annonce (277874) Données du registre: T 35221 , F 50, S 8, H M 425601, I/A 65 (26.06.18).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

27/06/2017 Détails de l'annonce (265225) Données du registre: T 35221 , F 49, S 8, H M 425601, I/A 64 (16.06.17).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 1.639.536,28 Euros. Resultante Suscrito: 9.017.449,54 Euros.

09/05/2017 Détails de l'annonce (194090) Données du registre: T 35221 , F 48, S 8, H M 425601, I/A 63 (27.04.17).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: AGUIRRE NEWMAN MADRID SA. Apo.Manc.: RAMIREZ DE HARO AGUIRRE FERNANDO;GUTIERREZ BRU JOSE MARIA. Apo.Sol.: ALVEZ OVIEDO MIRIAM.

10/02/2017 Détails de l'annonce (67991) Données du registre: T 35221 , F 48, S 8, H M 425601, I/A 62 ( 2.02.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: CERCADILLO CUERDA CARLOS;FERNANDEZ PARADELA BELEN;FERNANDEZ PARADELA SUSANA. VsecrNoConsj: CANSECO GARCIA-PITA TERESA. SecreNoConsj: BARON BASTARRECHE ALFONSO. Presidente: AGUIRRE GIL DE BIEDMA SANTIAGO. Consejero: LAFITA TORRES ALFREDO;EXINA SL;CERCUPENTA INTERNATIONAL B.V;CERCADILLO CUERDA NURIA;INVERSIONES SUBEL SL;INVERSIONES CALDE SL;INVERSIONES CLAUDIA SL;ISRAEL ABECASIS MOISES;AGUIRRE GIL DE BIEDMA SANTIAGO;CAIXA CATALUNYA GESTIO SGIIC SA;PROMOCIONES AL DESARROLLO BUMARI SOCIEDAD LIMITADA;ITURZAETA GOENAGA MIREN NEKANE;BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO. Representan: MARTI RABASSA XAVIER;RUBIO GARCIA CRISTINA;MOLINER ROBREDO FERNANDO;DE MUGUIRO MIRANDA JAVIER;LANDROVE BERMUDEZ JAVIER.

  • Nombramientos

    Liquidador: AMURA MANAGEMENT PARTNERS SL. Representan: COBO BUXENS ALVARO.

  • Disolución

    Otras Causas.

24/01/2017 Détails de l'annonce (35952) Données du registre: T 35221 , F 48, S 8, H M 425601, I/A 61 (17.01.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: LARUMBE ARBILLA MIREN IOSUNE.

  • Nombramientos

    Representan: MOLINER ROBREDO FERNANDO.

03/01/2017 Détails de l'annonce (3264) Données du registre: T 35221 , F 47, S 8, H M 425601, I/A 60 (21.12.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: ALVEZ TOLEDO MIRIAM.

29/11/2016 Détails de l'annonce (482775) Données du registre: T 35221 , F 47, S 8, H M 425601, I/A 59 (21.11.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: CORDERO GOMEZ RAQUEL.

  • Nombramientos

    Representan: RUBIO GARCIA CRISTINA.

18/11/2016 Détails de l'annonce (467210) Données du registre: T 23715 , F 217, S 8, H M 425601, I/A 12 (27.11.07).

  • Modificación de duración

    : 1.01.17.

  • Fe de erratas

    SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 12, LA FECHA FIN DE OPERACIONES, SIENDO LA CORRECTA 01/01/2017.

11/11/2016 Détails de l'annonce (453388) Données du registre: T 35221 , F 45, S 8, H M 425601, I/A 58 ( 2.11.16).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 22.133.739,78 Euros. Resultante Suscrito: 25.412.812,34 Euros.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 14.755.826,52 Euros. Resultante Suscrito: 10.656.985,82 Euros.

Documents connexes du registre du commerce: 54

#CVE
Date
Etat
BORME-A-2018-246-28 26/12/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-126-28 03/07/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-120-28 27/06/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-86-28 09/05/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-29-28 10/02/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-16-28 24/01/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-2-28 03/01/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-227-28 29/11/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-220-28 18/11/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-215-28 11/11/2016 Madrid Descargar