TRAP SA
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 24/06/2022 | LUMBY GEORGE PETER |
Administrador judicial |
| Cese: 24/06/2022 | PEREZ FERNANDEZ PAULINO SABINO |
Administrador judicial |
| Nombramiento: 16/07/2015 | LUMBY GEORGE PETER |
Administrador judicial |
| Nombramiento: 16/07/2015 | PEREZ FERNANDEZ PAULINO SABINO |
Administrador judicial |
| Cese: 18/06/2012 | DE CABO SANZ ANGEL |
Representante |
| Cese: 18/06/2012 | POSIBILITUMM BUSINESS SL |
Administrador único |
| Nombramiento: 18/06/2012 | LOPEZ GARCIA FELIPE |
Representante |
| Nombramiento: 18/06/2012 | OPEN TRADING SYSTEM SL |
Administrador único |
| Nombramiento: 27/07/2011 | CLEMENTE CUEVAS JULIAN |
Apoderado |
| Nombramiento: 22/07/2011 | GONZALVEZ BARRIOS JOSE MIGUEL |
Auditor suplente |
| Nombramiento: 22/07/2011 | MARTIN FELIX RODOLFO |
Auditor |
| Nombramiento: 10/01/2011 | CLEMENTE CUEVAS JULIAN |
Apoderado |
| Cese: 10/01/2011 | PASCUAL ARIAS GONZALO |
Consejero |
| Cese: 10/01/2011 | PASCUAL DE RIVA GONZALO-PASTOR |
Consejero |
| Cese: 10/01/2011 | DIAZ SANTAMARIA GERARDO |
Consejero |
| Cese: 10/01/2011 | PASCUAL ARIAS GONZALO |
Vicepresidente |
| Cese: 10/01/2011 | PASCUAL ARIAS GONZALO |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 10/01/2011 | INVERSIONES GRUDISAN SL |
Consejero |
| Cese: 10/01/2011 | INVERSIONES GRUDISAN SL |
Presidente |
| Cese: 10/01/2011 | INVERSIONES GRUDISAN SL |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 10/01/2011 | POSIBILITUMM BUSINESS SL |
Administrador único |
| Nombramiento: 10/01/2011 | DE CABO SANZ ANGEL |
Representante |
| Nombramiento: 14/04/2010 | CONTAFIDES AUDITORES SL |
Auditor |
| Cese: 15/03/2010 | LOPEZ CUADRADO SANTIAGO |
Apoderado |
| Nombramiento: 06/11/2009 | INVERSIONES GRUDISAN SL |
Consejero |
| Nombramiento: 06/11/2009 | INVERSIONES GRUDISAN SL |
Presidente |
| Nombramiento: 06/11/2009 | INVERSIONES GRUDISAN SL |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 06/11/2009 | DIAZ FERRAN GERARDO |
Representante |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por TRAP SA
24/06/2022 Detalles del anuncio (298206) Datos registrales: T 25595 , F 223, S 8, H M 44487, I/A 121 (17.06.22).
- Ceses/Dimisiones
Adm.Judicial: LUMBY GEORGE PETER;PEREZ FERNANDEZ PAULINO SABINO.
16/07/2015 Detalles del anuncio (292663) Datos registrales: T 25595 , F 223, S 8, H M 44487, I/A 120 ( 8.07.15).
- Nombramientos
Adm.Judicial: LUMBY GEORGE PETER;PEREZ FERNANDEZ PAULINO SABINO.
18/06/2012 Detalles del anuncio (256278) Datos registrales: T 25595 , F 222, S 8, H M 44487, I/A 119 ( 7.06.12).
- Ceses/Dimisiones
Representan: DE CABO SANZ ANGEL. Adm. Unico: POSIBILITUMM BUSINESS SL.
- Nombramientos
Representan: LOPEZ GARCIA FELIPE. Adm. Unico: OPEN TRADING SYSTEM SL.
13/09/2011 Detalles del anuncio (369493) Datos registrales: T 25595 , F 218, S 8, H M 44487, I/A 118 (25.08.11).
- Escisión Parcial
Sociedades beneficiarias de la escisión: EL SALADILLO SPORT SA.
01/09/2011 Detalles del anuncio (358810) Datos registrales: T 25595 , F 215, S 8, H M 44487, I/A 117 (17.08.11).
- Otros Conceptos
EL PATRIMONIO ESCINDIDO PARCIALMENTE HA SIDO TRASPASADO A LA SOCIEDAD DE NUEVA CREACION CIUDAD DEPORTIVA LA ALDEHUELA S.L..
- Escisión Parcial
Sociedades beneficiarias de la escisión: CIUDAD DEPORTIVA LA ALDEHUELA SL.
24/08/2011 Detalles del anuncio (349564) Datos registrales: T 25595 , F 210, S 8, H M 44487, I/A 116 ( 9.08.11).
- Escisión Parcial
Sociedades beneficiarias de la escisión: FITNESS BOADILLA SL.
24/08/2011 Detalles del anuncio (349563) Datos registrales: T 25595 , F 206, S 8, H M 44487, I/A 115 ( 9.08.11).
- Escisión Parcial
Sociedades beneficiarias de la escisión: CENTRO DEPORTIVO FUENTE DEL BERRO SL.
27/07/2011 Detalles del anuncio (311677) Datos registrales: T 25595 , F 206, S 8, H M 44487, I/A 114 (13.07.11).
- Nombramientos
Apoderado: CLEMENTE CUEVAS JULIAN.
22/07/2011 Detalles del anuncio (307762) Datos registrales: T 25595 , F 206, S 8, H M 44487, I/A 113 (11.07.11).
- Nombramientos
Aud.Supl.: GONZALVEZ BARRIOS JOSE MIGUEL. Auditor: MARTIN FELIX RODOLFO.
10/06/2011 Detalles del anuncio (171444)
- Depósitos de proyectos de escisión parcial
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 24
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2022-120-28 | 24/06/2022 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-133-28 | 16/07/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-114-28 | 18/06/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-174-28 | 13/09/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-167-28 | 01/09/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-161-28 | 24/08/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-161-28 | 24/08/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-142-28 | 27/07/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-140-28 | 22/07/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2011-111-28 | 10/06/2011 | Madrid | Descargar |