STAHL CRANESYSTEMS SL

Activa

AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 53 - NAV 11
 Alcobendas, Madrid  (28108)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 12/02/2018

ECHANOVE ORBEA JOAQUIN

Apoderado solidario
Nombramiento: 12/02/2018

LLANOS CAMARERO LAURA

Apoderado solidario
Nombramiento: 12/02/2018

GARCIA OLIVAN PABLO

Apoderado solidario
Nombramiento: 12/02/2018

NUÑO FERNANDEZ MONGE TERESA

Apoderado solidario
Nombramiento: 12/02/2018

CASTEÑEDA FERRER ALEJANDRA

Apoderado solidario
Cese: 10/08/2017

OTTOLA TEO JUHANI

Consejero
Cese: 10/08/2017

UTRIAINEN KARI JUHANI

Consejero
Cese: 10/08/2017

OTTOLA TEO JUHANI

Secretario
Cese: 10/08/2017

LEHTINEN AKU JUHANI

Consejero
Cese: 10/08/2017

LEHTINEN AKU JUHANI

Presidente
Nombramiento: 10/08/2017

HEINRICH WAGNER WERNER

Administrador único
Cese: 15/10/2012

BOYER PIERRE STEPHEN

Presidente
Cese: 15/10/2012

BOYER PIERRE STEPHEN

Consejero
Nombramiento: 15/10/2012

LEHTINEN AKU JUHANI

Consejero
Nombramiento: 15/10/2012

LEHTINEN AKU JUHANI

Presidente
Cese: 05/10/2010

PAKKILA PEKKA OLAVI

Consejero
Cese: 05/10/2010

PAKKILA PEKKA OLAVI

Presidente
Nombramiento: 05/10/2010

BOYER PIERRE STEPHEN

Consejero
Nombramiento: 05/10/2010

BOYER PIERRE STEPHEN

Presidente
Nombramiento: 24/02/2010

JULIAN CAMPAYO MARGARITA

Apoderado
Nombramiento: 24/02/2010

CABALLO ZABALLOS FRANCISCO

Apoderado
Cese: 04/09/2009

BRANDES SEBASTIAN HENNING

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por STAHL CRANESYSTEMS SL

12/02/2018 Detalles del anuncio (68073) Datos registrales: T 22012 , F 220, S 8, H M 392362, I/A 17 ( 2.02.18).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: ECHANOVE ORBEA JOAQUIN;LLANOS CAMARERO LAURA;GARCIA OLIVAN PABLO;NUÑO FERNANDEZ MONGE TERESA;CASTEÑEDA FERRER ALEJANDRA.

12/02/2018 Detalles del anuncio (68072) Datos registrales: T 22012 , F 102, S 8, H M 392362, I/A 16 ( 2.02.18).

  • Modificaciones Estatutarias

    Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3.

05/09/2017 Detalles del anuncio (360011) Datos registrales: T 22012 , F 102, S 8, H M 392362, I/A 15 (29.08.17).

  • Sociedad Unipersonal

    COLUMBUS MCKINNON IBERICA SL.

10/08/2017 Detalles del anuncio (331730) Datos registrales: T 22012 , F 102, S 8, H M 392362, I/A 14 ( 2.08.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: OTTOLA TEO JUHANI;UTRIAINEN KARI JUHANI. Secretario: OTTOLA TEO JUHANI. Consejero: LEHTINEN AKU JUHANI. Presidente: LEHTINEN AKU JUHANI.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: HEINRICH WAGNER WERNER.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

15/10/2012 Detalles del anuncio (418393) Datos registrales: T 22012 , F 101, S 8, H M 392362, I/A 13 ( 1.10.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: BOYER PIERRE STEPHEN. Consejero: BOYER PIERRE STEPHEN.

  • Nombramientos

    Consejero: LEHTINEN AKU JUHANI. Presidente: LEHTINEN AKU JUHANI.

20/07/2011 Detalles del anuncio (218271)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2011) Año: 2010

11/11/2010 Detalles del anuncio (1024689)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2010) Año: 2009

05/10/2010 Detalles del anuncio (372382) Datos registrales: T 22012 , F 101, S 8, H M 392362, I/A 12 (22.09.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: PAKKILA PEKKA OLAVI. Presidente: PAKKILA PEKKA OLAVI.

  • Nombramientos

    Consejero: BOYER PIERRE STEPHEN. Presidente: BOYER PIERRE STEPHEN.

24/02/2010 Detalles del anuncio (79348) Datos registrales: T 22012 , F 100, S 8, H M 392362, I/A 11 (15.02.10).

  • Nombramientos

    Apoderado: JULIAN CAMPAYO MARGARITA;CABALLO ZABALLOS FRANCISCO.

14/10/2009 Detalles del anuncio (656386)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2009) Año: 2008

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2018-30-28 12/02/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-30-28 12/02/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-169-28 05/09/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-152-28 10/08/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2012-198-28 15/10/2012 Madrid Descargar
BORME-B-2011-138-28 20/07/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-216-28 11/11/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-192-28 05/10/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-37-28 24/02/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2009-196-28 14/10/2009 Madrid Descargar