SERVEIS PLUSKABA SL

Activa

C/ ARTE 21 5ª B (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 09/04/2021

FARRE FERNANDEZ JOSE MANUEL

Administrador único
Nombramiento: 09/04/2021

SEGER SEGURA JOSE

Administrador único
Nombramiento: 30/11/2017

SEGER SEGURA JOSE

Apoderado solidario
Cese: 19/08/2009

POUS RIVERO SARA

Administrador único
Nombramiento: 19/08/2009

FARRE FERNANDEZ JOSE MANUEL

Administrador único
Cese: 13/07/2009

IURIS ASSESSORS I GESTORS SL

Administrador único
Cese: 13/07/2009

BLAZQUEZ QUEVEDO SERGI

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 13/07/2009

POUS RIVERO SARA

Administrador único
Nombramiento: 25/05/2009

IURIS ASSESSORS I GESTORS SL

Administrador único
Nombramiento: 25/05/2009

BLAZQUEZ QUEVEDO SERGI

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SERVEIS PLUSKABA SL

14/02/2022 Detalles del anuncio (65470) Datos registrales: T 41520 , F 185, S 8, H M 735732, I/A 3 ( 7.02.22).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 20.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.006,00 Euros.

09/04/2021 Detalles del anuncio (162492) Datos registrales: T 41520 , F 185, S 8, H M 735732, I/A 2 (31.03.21).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: FARRE FERNANDEZ JOSE MANUEL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: SEGER SEGURA JOSE.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 2.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.006,00 Euros.

  • Cambio de domicilio social

    C/ ARTE 21 5ª B (MADRID).

02/04/2020 Detalles del anuncio (137996) Datos registrales: T 46246 , F 31, S 8, H B 382924, I/A 7 (24.03.20).

  • Cambio de domicilio social

    GV DE LES CORTS CATALANES NUM.798 LOCAL (BARCELONA).

30/11/2017 Detalles del anuncio (470833) Datos registrales: T 41212 , F 130, S 8, H B 382924, I/A 6 (22.11.17).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: SEGER SEGURA JOSE.

22/11/2011 Detalles del anuncio (953373)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2011) Año: 2010

22/12/2010 Detalles del anuncio (1169144)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Noviembre de 2010) Año: 2009

06/07/2010 Detalles del anuncio (266733) Datos registrales: T 41212 , F 130, S 8, H B 382924, I/A 5 (23.06.10).

  • Cambio de domicilio social

    CL CASANOVA NUM.43 ENT.3 IZ (BARCELONA).

20/10/2009 Detalles del anuncio (434937) Datos registrales: T 41212 , F 130, S 8, H B 382924, I/A 4 ( 6.10.09).

  • Cambio de objeto social

    AMPLIAR A:LA FABRICACION,LA INTERMEDIACION,LA COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y AL DETALLE,LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE APARATOS ELECTRONICOS E INFORMATICA,ASI COMO LA DE TODOS SUS COMPONENTES,RECAMBIOS,ACCESORIOS...

19/08/2009 Detalles del anuncio (362551) Datos registrales: T 41212 , F 129, S 8, H B 382924, I/A 3 ( 7.08.09).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: POUS RIVERO SARA.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: FARRE FERNANDEZ JOSE MANUEL.

13/07/2009 Detalles del anuncio (311750) Datos registrales: T 41212 , F 129, S 8, H B 382924, I/A 2 ( 1.07.09).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: IURIS ASSESSORS I GESTORS SL. REPR.143 RRM: BLAZQUEZ QUEVEDO SERGI.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: POUS RIVERO SARA.

  • Cambio de domicilio social

    CL ANGEL GUIMERA Num.11 P.3 PTA.1 (SANT CUGAT DEL VALLES).

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-30-28 14/02/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-66-28 09/04/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-65-08 02/04/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-228-08 30/11/2017 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-221-08 22/11/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-243-08 22/12/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-127-08 06/07/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-200-08 20/10/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-157-08 19/08/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-130-08 13/07/2009 Barcelona Descargar