SCRIPTA CONTENIDOS SL

Extinta

POLIGONO GALARIA, CALLE V, nº 3 OFICINA 1C,CORDOVI (GALAR).
 Gáldar, Palmas, Las
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 13/03/2014

ORTEGA CATALAN JUAN JOSE

Liquidador único
Cese: 13/03/2014

GUERRERO GUTIERREZ JOSE MANUEL

Apoderado
Cese: 15/11/2013

COFOR NAVARRA SL

Consejero
Cese: 15/11/2013

HELPHONE SERVICIOS INFORMATICOS SL

Consejero
Cese: 15/11/2013

COFOR NAVARRA SL

Presidente
Cese: 15/11/2013

START UP CAPITAL NAVARRA SA

Consejero
Cese: 15/11/2013

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA

Consejero
Nombramiento: 15/11/2013

ORTEGA CATALAN JUAN JOSE

Liquidador único
Nombramiento: 28/03/2012

GUERRERO GUTIERREZ JOSE MANUEL

Apoderado
Cese: 13/03/2012

FRAUCA ECHANDI PABLO

Apoderado
Cese: 13/03/2012

MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Cese: 08/03/2012

LA INFORMACION SA

Consejero
Cese: 08/03/2012

AZNAREZ IRIARTE PEDRO JESUS

Consejero
Cese: 08/03/2012

LA INFORMACION SA

Presidente
Cese: 08/03/2012

HELPHONE SERVICIOS INFORMATICOS SL

Secretario
Nombramiento: 08/03/2012

ORTEGA CATALAN JUAN JOSE

Secretario no consejero
Nombramiento: 08/03/2012

COFOR NAVARRA SL

Presidente
Nombramiento: 08/03/2012

START UP CAPITAL NAVARRA SA

Consejero
Nombramiento: 08/03/2012

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA

Consejero
Nombramiento: 22/10/2010

FRAUCA ECHANDI PABLO

Apoderado
Nombramiento: 22/10/2010

MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Cese: 22/10/2010

GELBENZU LAPRESTA JORGE

Apoderado
Nombramiento: 22/06/2010

GELBENZU LAPRESTA JORGE

Apoderado
Cese: 22/06/2010

MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

Consejero
Cese: 22/06/2010

MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

Secretario
Nombramiento: 22/06/2010

HELPHONE SERVICIOS INFORMATICOS SL

Consejero
Nombramiento: 22/06/2010

HELPHONE SERVICIOS INFORMATICOS SL

Secretario
Nombramiento: 04/12/2009

LA INFORMACION SA

Consejero
Nombramiento: 04/12/2009

COFOR NAVARRA SL

Consejero
Nombramiento: 04/12/2009

MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

Consejero
Nombramiento: 04/12/2009

AZNAREZ IRIARTE PEDRO JESUS

Consejero
Nombramiento: 04/12/2009

LA INFORMACION SA

Presidente
Nombramiento: 04/12/2009

MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

Secretario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SCRIPTA CONTENIDOS SL

13/03/2014 Detalles del anuncio (115628) Datos registrales: T 1498 , F 161, S 8, H NA 29548, I/A 15 (28.02.14).

  • Ceses/Dimisiones

    LiqUnico: ORTEGA CATALAN JUAN JOSE.

  • Revocaciones

    Apoderado: GUERRERO GUTIERREZ JOSE MANUEL.

  • Extinción

    Depósito de libros.

15/11/2013 Detalles del anuncio (489069) Datos registrales: T 1498 , F 161, S 8, H NA 29548, I/A 14 ( 7.11.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: COFOR NAVARRA SL;HELPHONE SERVICIOS INFORMATICOS SL. Presidente: COFOR NAVARRA SL. Consejero: START UP CAPITAL NAVARRA SA;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA.

  • Nombramientos

    LiqUnico: ORTEGA CATALAN JUAN JOSE.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico.

  • Disolución

    Voluntaria.

09/10/2012 Detalles del anuncio (412401) Datos registrales: T 1498 , F 161, S 8, H NA 29548, I/A 13 (20.09.12).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 240.584,00 Euros. Resultante Suscrito: 691.034,00 Euros.

07/08/2012 Detalles del anuncio (331624) Datos registrales: T 1498 , F 161, S 8, H NA 29548, I/A 12 (26.07.12).

  • Otros Conceptos

    CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA sustituyó a supersona física representante en el cargo de consejero, designando a Don Julián Aldaz Garriz.

28/03/2012 Detalles del anuncio (144604) Datos registrales: T 1498 , F 160, S 8, H NA 29548, I/A 11 (16.03.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: GUERRERO GUTIERREZ JOSE MANUEL.

13/03/2012 Detalles del anuncio (120841) Datos registrales: T 1498 , F 160, S 8, H NA 29548, I/A 10 (24.02.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: FRAUCA ECHANDI PABLO;MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.

08/03/2012 Detalles del anuncio (113027) Datos registrales: T 1498 , F 158, S 8, H NA 29548, I/A 9 (24.02.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: LA INFORMACION SA;AZNAREZ IRIARTE PEDRO JESUS. Presidente: LA INFORMACION SA. Secretario: HELPHONE SERVICIOS INFORMATICOS SL.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: ORTEGA CATALAN JUAN JOSE. Presidente: COFOR NAVARRA SL. Consejero: START UP CAPITAL NAVARRA SA;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 200.450,00 Euros. Resultante Suscrito: 450.450,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 10º, 11º, 17º y 20º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

24/08/2011 Detalles del anuncio (349367)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

10/02/2011 Detalles del anuncio (60542) Datos registrales: T 1498 , F 158, S 8, H NA 29548, I/A 8 (25.01.11).

  • Otros Conceptos

    NOMBRAR como representante físico de COFOR NAVARRA SL, en el consejo de administración de SCRIPTA CONTENIDOS SL, a DON PABLO FRAUCA ECHANDI, con D.N.I. 33.427.258-R, en sustitución de Don Oscar Matellanes García.

22/10/2010 Detalles del anuncio (392404) Datos registrales: T 1487 , F 70, S 8, H NA029548, I/A00007 (11.10.10).

  • Nombramientos

    Apoderado: FRAUCA ECHANDI PABLO;MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 17

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2014-50-31 13/03/2014 Navarra Descargar
BORME-A-2013-219-31 15/11/2013 Navarra Descargar
BORME-A-2012-195-31 09/10/2012 Navarra Descargar
BORME-A-2012-150-31 07/08/2012 Navarra Descargar
BORME-A-2012-61-31 28/03/2012 Navarra Descargar
BORME-A-2012-51-31 13/03/2012 Navarra Descargar
BORME-A-2012-48-31 08/03/2012 Navarra Descargar
BORME-B-2011-161-31 24/08/2011 Navarra Descargar
BORME-A-2011-28-31 10/02/2011 Navarra Descargar
BORME-A-2010-204-31 22/10/2010 Navarra Descargar