PROYECTO R5 SL

Extinta

C/ PADILLA, 42, 1 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 31/10/2013

ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO

Consejero
Cese: 31/10/2013

CARDENAL HURTADO DE SARACHO JAVIER

Consejero
Cese: 31/10/2013

ALFONSO SANCHEZ ANTONIO JOSE

Consejero
Cese: 31/10/2013

OZAMIZ ESTRADE JAVIER

Consejero
Cese: 31/10/2013

VIZCAYA RETANA MARCOS

Consejero
Cese: 31/10/2013

BAON MARTINEZ LUIS

Consejero
Cese: 31/10/2013

CARDENAS HURTADO DE SARACHO IÑIGO

Consejero
Cese: 31/10/2013

ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO

Presidente
Cese: 31/10/2013

ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO

Consejero delegado
Cese: 31/10/2013

HENRIQUEZ DE LUNA BASAGOITI MANUEL

Vicesecretario
Cese: 31/10/2013

PASTOR PINEDO IÑIGO

Secretario
Nombramiento: 31/10/2013

ISUSI GARTEIZ-GOGEASCOA ALBERTO

Liquidador
Cese: 31/05/2011

SANCHEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 12/05/2010

ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SLP

Auditor
Nombramiento: 05/01/2010

CARDENAL HURTADO DE SARACHO JAVIER

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por PROYECTO R5 SL

31/10/2013 Detalles del anuncio (466317) Datos registrales: T 27131 , F 82, S 8, H M 420181, I/A 10 (24.10.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO;CARDENAL HURTADO DE SARACHO JAVIER;ALFONSO SANCHEZ ANTONIO JOSE;OZAMIZ ESTRADE JAVIER;VIZCAYA RETANA MARCOS;BAON MARTINEZ LUIS;CARDENAS HURTADO DE SARACHO IÑIGO. Presidente: ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO. Con.Delegado: ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO. Vicesecret.: HENRIQUEZ DE LUNA BASAGOITI MANUEL. Secretario: PASTOR PINEDO IÑIGO.

  • Nombramientos

    Liquidador: ISUSI GARTEIZ-GOGEASCOA ALBERTO.

  • Disolución

    Voluntaria.

31/05/2011 Detalles del anuncio (231682) Datos registrales: T 27131 , F 81, S 8, H M 420181, I/A 9 (19.05.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: SANCHEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO.

12/05/2011 Detalles del anuncio (149888)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Abril de 2011) Año: 2010

04/04/2011 Detalles del anuncio (149903) Datos registrales: T 27131 , F 80, S 8, H M 420181, I/A 8 (24.03.11).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 849.996,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.675.756,00 Euros.

15/06/2010 Detalles del anuncio (205843)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Mayo de 2010) Año: 2009

12/05/2010 Detalles del anuncio (190573) Datos registrales: T 27131 , F 80, S 8, H M 420181, I/A 7 (29.04.10).

  • Nombramientos

    Auditor: ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SLP.

25/01/2010 Detalles del anuncio (28606) Datos registrales: T 27131 , F 80, S 8, H M 420181, I/A 6 (14.01.10).

  • Cambio de domicilio social

    C/ PADILLA, 42, 1 (MADRID).

05/01/2010 Detalles del anuncio (3695) Datos registrales: T 23427 , F 169, S 8, H M 420181, I/A 5 (23.12.09).

  • Nombramientos

    Apoderado: CARDENAL HURTADO DE SARACHO JAVIER.

22/06/2009 Detalles del anuncio (148894)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Junio de 2009) Año: 2008

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 9

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2013-209-28 31/10/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2011-103-28 31/05/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2011-90-28 12/05/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-65-28 04/04/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-112-28 15/06/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-89-28 12/05/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-15-28 25/01/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-2-28 05/01/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2009-115-28 22/06/2009 Madrid Descargar