MEGAOCIO COMPLEJOS DE OCIO METROPOLITANO SL

Activa

AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 28 - ED DOMOCENTER PLT 1
 Bormujos, Sevilla  (41930)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 17/10/2014

TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE

Administrador único
Nombramiento: 06/06/2011

MARIA DEL CARMEN MONTSERRAT ROMERA GARCIA

Apoderado
Cese: 06/04/2011

ROMERA GARCIA MARIA DEL CARMEN MONTSERRAT

Consejero
Cese: 06/04/2011

ROMERA GARCIA MARIA DEL CARMEN MONTSERRAT

Presidente
Cese: 06/04/2011

CAMINO MARTIN MANUEL

Consejero
Cese: 06/04/2011

CAMINO MARTIN MANUEL

Secretario
Cese: 06/04/2011

MARTINEZ DE ASPE FILOMENO

Consejero
Cese: 06/04/2011

TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE

Consejero
Cese: 06/04/2011

DUMONT SPINOLA RAFAEL

Consejero
Cese: 06/04/2011

LOPEZ AGUADO ANTONIO FRANCISCO

Consejero
Cese: 06/04/2011

MARTINEZ DE ASPE FILOMENO

Consejero delegado mancomunado
Cese: 06/04/2011

TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 06/04/2011

TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE

Administrador único
Cese: 22/12/2009

MUÑOZ SANCHEZ FRANCISCO

Consejero
Cese: 22/12/2009

MARIA CARMEN MONTSERRAT ROMERA GARCIA

Consejero
Cese: 22/12/2009

MANUEL CAMINO MARTIN

Consejero
Cese: 22/12/2009

MANUEL CAMINO MARTIN

Secretario
Cese: 22/12/2009

MARTINEZ DE ASPE FILOMENO

Consejero
Cese: 22/12/2009

TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE

Consejero
Cese: 22/12/2009

DUMONT SPINOLA RAFAEL

Consejero
Cese: 22/12/2009

MARTINEZ DE ASPE FILOMENO

Consejero delegado mancomunado
Cese: 22/12/2009

TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE

Consejero delegado mancomunado
Cese: 22/12/2009

CARBAJOSA FERNANDEZ CARLOS ANTONIO

Consejero
Cese: 22/12/2009

FERNANDO JOSE MARTINEZ DE ASPE

Consejero
Cese: 22/12/2009

MARIA CARMEN MONTSERRAT ROMERA GARCIA

Presidente
Nombramiento: 22/12/2009

ROMERA GARCIA MARIA DEL CARMEN MONTSERRAT

Consejero
Nombramiento: 22/12/2009

ROMERA GARCIA MARIA DEL CARMEN MONTSERRAT

Presidente
Nombramiento: 22/12/2009

CAMINO MARTIN MANUEL

Consejero
Nombramiento: 22/12/2009

CAMINO MARTIN MANUEL

Secretario
Nombramiento: 22/12/2009

MARTINEZ DE ASPE FILOMENO

Consejero
Nombramiento: 22/12/2009

TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE

Consejero
Nombramiento: 22/12/2009

DUMONT SPINOLA RAFAEL

Consejero
Nombramiento: 22/12/2009

LOPEZ AGUADO ANTONIO FRANCISCO

Consejero
Nombramiento: 22/12/2009

MARTINEZ DE ASPE FILOMENO

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 22/12/2009

TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE

Consejero delegado mancomunado
Cese: 06/05/2009

MARTINEZ ASPE FILOMENO

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por MEGAOCIO COMPLEJOS DE OCIO METROPOLITANO SL

18/08/2017 Detalles del anuncio (341130) Datos registrales: T 5992 , F 106, S 8, H SE 41952, I/A 20 ( 9.08.17).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 1.483.812,00 Euros. Resultante Suscrito: 82.434,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 6º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

16/07/2015 Detalles del anuncio (293510) Datos registrales: T 5992 , F 105, S 8, H SE 41952, I/A 19 ( 9.07.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 1.648.680,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.566.246,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 6. Capital.-.

18/03/2015 Detalles del anuncio (117300) Datos registrales: T 5341 , F 115, S 8, H SE 41952, I/A 18 (11.03.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 906.774,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.214.926,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 6. Capital.-.

  • Escisión Parcial

    Sociedades beneficiarias de la escisión: AL ANDALUS MULTICINES BORMUJOS, SOCIEDAD LIMITADA.

17/02/2015 Detalles del anuncio (70994) Datos registrales: T 5341 , F 115, S 8, H SE 41952, I/A 17 (10.02.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 64.780,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.121.700,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 6. Capital.-.

31/10/2014 Detalles del anuncio (440797) Datos registrales: T 5341 , F 114, S 8, H SE 41952, I/A 16 (23.10.14).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 449.110,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.186.480,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 6. Capital.-.

17/10/2014 Detalles del anuncio (417905) Datos registrales: T 5341 , F 111, S 8, H SE 41952, I/A 15 (30.09.14).

  • Transformación de Sociedad

    Denominación y forma adoptada: MEGAOCIO COMPLEJOS DE OCIO METROPOLITANO SL.

  • Reelecciones

    Adm. Unico: TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: MODIFICACION TOTAL DE ESTATUTOS..

31/01/2013 Detalles del anuncio (49182) Datos registrales: T 5341 , F 109, S 8, H SE 41952, I/A 14 (22.01.13).

  • Fusión por Absorción

    Sociedades absorbidas: K CHE MUSIC SL.

12/12/2011 Detalles del anuncio (975299)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Noviembre de 2011) Año: 2010

06/06/2011 Detalles del anuncio (240850) Datos registrales: T 5341 , F 108, S 8, H SE 41952, I/A 12 (17.05.11).

  • Nombramientos

    Apoderado: MARIA DEL CARMEN MONTSERRAT ROMERA GARCIA.

06/04/2011 Detalles del anuncio (154027) Datos registrales: T 3140 , F 45, S 8, H SE 41952, I/A 12 (24.03.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ROMERA GARCIA MARIA DEL CARMEN MONTSERRAT. Presidente: ROMERA GARCIA MARIA DEL CARMEN MONTSERRAT. Consejero: CAMINO MARTIN MANUEL. Secretario: CAMINO MARTIN MANUEL. Consejero: MARTINEZ DE ASPE FILOMENO;TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE;DUMONT SPINOLA RAFAEL;LOPEZ AGUADO ANTONIO FRANCISCO. Cons.Del.Man: MARTINEZ DE ASPE FILOMENO;TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: TRONCOSO MARTINEZ FERNANDO JOSE.

  • Modificaciones Estatutarias

    6. Acciones/Participaciones.- 11º y 14º y se refunden totalmente los estatutos.Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 15

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2017-157-41 18/08/2017 Sevilla Descargar
BORME-A-2015-133-41 16/07/2015 Sevilla Descargar
BORME-A-2015-53-41 18/03/2015 Sevilla Descargar
BORME-A-2015-32-41 17/02/2015 Sevilla Descargar
BORME-A-2014-209-41 31/10/2014 Sevilla Descargar
BORME-A-2014-199-41 17/10/2014 Sevilla Descargar
BORME-A-2013-21-41 31/01/2013 Sevilla Descargar
BORME-B-2011-233-41 12/12/2011 Sevilla Descargar
BORME-A-2011-107-41 06/06/2011 Sevilla Descargar
BORME-A-2011-67-41 06/04/2011 Sevilla Descargar