MARINE INTEGRATED SOLUTIONS SL

Activa

AVENIDA BEIRAMAR, 75
 Vigo, Pontevedra  (36202)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 19/11/2019

PEREZ COSTAS FERNANDO

Apoderado solidario
Nombramiento: 19/11/2019

CASAS LOPEZ MARIA DEL CARMEN

Apoderado solidario
Cese: 03/04/2018

BENITO JIMENEZ ALEJANDRO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 03/04/2018

VARELA SENIN NELA

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 03/04/2018

PEREZ COSTAS FERNANDO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 03/04/2018

SILVEIRA CORREA RAIMUNDO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 03/04/2018

SALZMANN VIKTOR

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 03/04/2018

GRIFFIN DOUGLAS CLYDE

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 03/04/2018

GARCIA COSTAS JOSE

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 03/04/2018

GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 14/02/2018

GARCIA COSTAS JOSE

Presidente
Cese: 14/02/2018

GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL

Secretario
Cese: 14/02/2018

SALZMANN VIKTOR

Vicepresidente
Cese: 14/02/2018

GARCIA COSTAS JOSE

Consejero
Cese: 14/02/2018

PEREZ COSTAS FERNANDO

Consejero
Cese: 14/02/2018

GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL

Consejero
Cese: 14/02/2018

SALZMANN VIKTOR

Consejero
Cese: 14/02/2018

DOUGLAS GRIFFIN CLYDE

Consejero
Cese: 14/02/2018

BENITO JIMENEZ ALEJANDRO

Consejero
Cese: 14/02/2018

DE LA CRUZ MARTINEZ JAVIER

Letrado asesor
Nombramiento: 14/02/2018

GARCIA COSTAS JOSE

Administrador único
Nombramiento: 18/08/2015

SALZMANN VIKTOR

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/08/2015

DOUGLAS GRIFFIN CLYDE

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/08/2015

GARCIA COSTAS JOSE

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/08/2015

GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/08/2015

BENITO JIMENEZ ALEJANDRO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/08/2015

VARELA SENIN NELA

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/08/2015

PEREZ COSTAS FERNANDO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/08/2015

SILVEIRA CORREA RAIMUNDO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 28/07/2015

GARCIA COSTAS JOSE

Presidente
Nombramiento: 28/07/2015

GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL

Secretario
Nombramiento: 28/07/2015

SALZMANN VIKTOR

Vicepresidente
Nombramiento: 28/07/2015

DE LA CRUZ MARTINEZ JAVIER

Letrado asesor
Nombramiento: 28/07/2015

GARCIA COSTAS JOSE

Consejero
Nombramiento: 28/07/2015

PEREZ COSTAS FERNANDO

Consejero
Nombramiento: 28/07/2015

GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL

Consejero
Nombramiento: 28/07/2015

SALZMANN VIKTOR

Consejero
Nombramiento: 28/07/2015

DOUGLAS GRIFFIN CLYDE

Consejero
Nombramiento: 28/07/2015

BENITO JIMENEZ ALEJANDRO

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por MARINE INTEGRATED SOLUTIONS SL

19/11/2019 Detalles del anuncio (478494) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 209, S 8, H PO 58771, I/A 11 (11.11.19).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: PEREZ COSTAS FERNANDO;CASAS LOPEZ MARIA DEL CARMEN.

03/04/2018 Detalles del anuncio (148664) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 209, S 8, H PO 58771, I/A 10 (23.03.18).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: BENITO JIMENEZ ALEJANDRO;VARELA SENIN NELA;PEREZ COSTAS FERNANDO;SILVEIRA CORREA RAIMUNDO;SALZMANN VIKTOR;GRIFFIN DOUGLAS CLYDE;GARCIA COSTAS JOSE;GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL.

19/03/2018 Detalles del anuncio (125855) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 207, S 8, H PO 58771, I/A 9 ( 9.03.18).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.000,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12.

  • Otros Conceptos

    Se REFUNDEN los Estatutos Sociales.

14/02/2018 Detalles del anuncio (73427) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 206, S 8, H PO 58771, I/A 8 ( 6.02.18).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    ELECTROMECANICA NAVAL E INDUSTRIAL SA.

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Secretario: GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL. Vicepresid.: SALZMANN VIKTOR. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE;PEREZ COSTAS FERNANDO;GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL;SALZMANN VIKTOR;DOUGLAS GRIFFIN CLYDE;BENITO JIMENEZ ALEJANDRO. L. Asesor: DE LA CRUZ MARTINEZ JAVIER.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: GARCIA COSTAS JOSE.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. El socio único en acto de fecha 12/01/2018 adopta la decisión de modificar los artículos 11º y 18º de los estatutos sociales.

05/01/2018 Detalles del anuncio (8308) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 206, S 8, H PO 58771, I/A 7 (27.12.17).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 600.000,00 Euros.

18/04/2017 Detalles del anuncio (168748) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 206, S 8, H PO 58771, I/A 6 ( 6.04.17).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 450.000,00 Euros.

31/08/2016 Detalles del anuncio (361310) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 206, S 8, H PO 58771, I/A 5 (23.08.16).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros.

18/08/2015 Detalles del anuncio (343373) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 204, S 8, H PO 58771, I/A 4 (11.08.15).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: SALZMANN VIKTOR;DOUGLAS GRIFFIN CLYDE;GARCIA COSTAS JOSE;GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL.

18/08/2015 Detalles del anuncio (343372) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 203, S 8, H PO 58771, I/A 3 (11.08.15).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: BENITO JIMENEZ ALEJANDRO;VARELA SENIN NELA;PEREZ COSTAS FERNANDO;SILVEIRA CORREA RAIMUNDO.

28/07/2015 Detalles del anuncio (312307) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 203, S 8, H PO 58771, I/A 2 (16.07.15).

  • Nombramientos

    Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Secretario: GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL. Vicepresid.: SALZMANN VIKTOR. L. Asesor: DE LA CRUZ MARTINEZ JAVIER.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2019-222-36 19/11/2019 Pontevedra Descargar
BORME-A-2018-64-36 03/04/2018 Pontevedra Descargar
BORME-A-2018-55-36 19/03/2018 Pontevedra Descargar
BORME-A-2018-32-36 14/02/2018 Pontevedra Descargar
BORME-A-2018-4-36 05/01/2018 Pontevedra Descargar
BORME-A-2017-73-36 18/04/2017 Pontevedra Descargar
BORME-A-2016-166-36 31/08/2016 Pontevedra Descargar
BORME-A-2015-156-36 18/08/2015 Pontevedra Descargar
BORME-A-2015-156-36 18/08/2015 Pontevedra Descargar
BORME-A-2015-141-36 28/07/2015 Pontevedra Descargar