MARINE INTEGRATED SOLUTIONS SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 19/11/2019 | PEREZ COSTAS FERNANDO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 19/11/2019 | CASAS LOPEZ MARIA DEL CARMEN |
Apoderado solidario |
| Cese: 03/04/2018 | BENITO JIMENEZ ALEJANDRO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 03/04/2018 | VARELA SENIN NELA |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 03/04/2018 | PEREZ COSTAS FERNANDO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 03/04/2018 | SILVEIRA CORREA RAIMUNDO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 03/04/2018 | SALZMANN VIKTOR |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 03/04/2018 | GRIFFIN DOUGLAS CLYDE |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 03/04/2018 | GARCIA COSTAS JOSE |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 03/04/2018 | GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 14/02/2018 | GARCIA COSTAS JOSE |
Presidente |
| Cese: 14/02/2018 | GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL |
Secretario |
| Cese: 14/02/2018 | SALZMANN VIKTOR |
Vicepresidente |
| Cese: 14/02/2018 | GARCIA COSTAS JOSE |
Consejero |
| Cese: 14/02/2018 | PEREZ COSTAS FERNANDO |
Consejero |
| Cese: 14/02/2018 | GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL |
Consejero |
| Cese: 14/02/2018 | SALZMANN VIKTOR |
Consejero |
| Cese: 14/02/2018 | DOUGLAS GRIFFIN CLYDE |
Consejero |
| Cese: 14/02/2018 | BENITO JIMENEZ ALEJANDRO |
Consejero |
| Cese: 14/02/2018 | DE LA CRUZ MARTINEZ JAVIER |
Letrado asesor |
| Nombramiento: 14/02/2018 | GARCIA COSTAS JOSE |
Administrador único |
| Nombramiento: 18/08/2015 | SALZMANN VIKTOR |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 18/08/2015 | DOUGLAS GRIFFIN CLYDE |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 18/08/2015 | GARCIA COSTAS JOSE |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 18/08/2015 | GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 18/08/2015 | BENITO JIMENEZ ALEJANDRO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 18/08/2015 | VARELA SENIN NELA |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 18/08/2015 | PEREZ COSTAS FERNANDO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 18/08/2015 | SILVEIRA CORREA RAIMUNDO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 28/07/2015 | GARCIA COSTAS JOSE |
Presidente |
| Nombramiento: 28/07/2015 | GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL |
Secretario |
| Nombramiento: 28/07/2015 | SALZMANN VIKTOR |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 28/07/2015 | DE LA CRUZ MARTINEZ JAVIER |
Letrado asesor |
| Nombramiento: 28/07/2015 | GARCIA COSTAS JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 28/07/2015 | PEREZ COSTAS FERNANDO |
Consejero |
| Nombramiento: 28/07/2015 | GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL |
Consejero |
| Nombramiento: 28/07/2015 | SALZMANN VIKTOR |
Consejero |
| Nombramiento: 28/07/2015 | DOUGLAS GRIFFIN CLYDE |
Consejero |
| Nombramiento: 28/07/2015 | BENITO JIMENEZ ALEJANDRO |
Consejero |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por MARINE INTEGRATED SOLUTIONS SL
19/11/2019 Detalles del anuncio (478494) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 209, S 8, H PO 58771, I/A 11 (11.11.19).
- Nombramientos
Apo.Sol.: PEREZ COSTAS FERNANDO;CASAS LOPEZ MARIA DEL CARMEN.
03/04/2018 Detalles del anuncio (148664) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 209, S 8, H PO 58771, I/A 10 (23.03.18).
- Revocaciones
Apo.Man.Soli: BENITO JIMENEZ ALEJANDRO;VARELA SENIN NELA;PEREZ COSTAS FERNANDO;SILVEIRA CORREA RAIMUNDO;SALZMANN VIKTOR;GRIFFIN DOUGLAS CLYDE;GARCIA COSTAS JOSE;GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL.
19/03/2018 Detalles del anuncio (125855) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 207, S 8, H PO 58771, I/A 9 ( 9.03.18).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.000,00 Euros.
- Modificaciones Estatutarias
Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12.
- Otros Conceptos
Se REFUNDEN los Estatutos Sociales.
14/02/2018 Detalles del anuncio (73427) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 206, S 8, H PO 58771, I/A 8 ( 6.02.18).
- Declaración de unipersonalidad. Socio Único.
ELECTROMECANICA NAVAL E INDUSTRIAL SA.
- Ceses/Dimisiones
Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Secretario: GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL. Vicepresid.: SALZMANN VIKTOR. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE;PEREZ COSTAS FERNANDO;GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL;SALZMANN VIKTOR;DOUGLAS GRIFFIN CLYDE;BENITO JIMENEZ ALEJANDRO. L. Asesor: DE LA CRUZ MARTINEZ JAVIER.
- Nombramientos
Adm. Unico: GARCIA COSTAS JOSE.
- Otros Conceptos
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. El socio único en acto de fecha 12/01/2018 adopta la decisión de modificar los artículos 11º y 18º de los estatutos sociales.
05/01/2018 Detalles del anuncio (8308) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 206, S 8, H PO 58771, I/A 7 (27.12.17).
- Ampliación de Capital
Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 600.000,00 Euros.
18/04/2017 Detalles del anuncio (168748) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 206, S 8, H PO 58771, I/A 6 ( 6.04.17).
- Ampliación de Capital
Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 450.000,00 Euros.
31/08/2016 Detalles del anuncio (361310) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 206, S 8, H PO 58771, I/A 5 (23.08.16).
- Ampliación de Capital
Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros.
18/08/2015 Detalles del anuncio (343373) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 204, S 8, H PO 58771, I/A 4 (11.08.15).
- Nombramientos
Apo.Man.Soli: SALZMANN VIKTOR;DOUGLAS GRIFFIN CLYDE;GARCIA COSTAS JOSE;GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL.
18/08/2015 Detalles del anuncio (343372) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 203, S 8, H PO 58771, I/A 3 (11.08.15).
- Nombramientos
Apo.Man.Soli: BENITO JIMENEZ ALEJANDRO;VARELA SENIN NELA;PEREZ COSTAS FERNANDO;SILVEIRA CORREA RAIMUNDO.
28/07/2015 Detalles del anuncio (312307) Datos registrales: T 4054, L 4054, F 203, S 8, H PO 58771, I/A 2 (16.07.15).
- Nombramientos
Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Secretario: GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL. Vicepresid.: SALZMANN VIKTOR. L. Asesor: DE LA CRUZ MARTINEZ JAVIER.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2019-222-36 | 19/11/2019 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2018-64-36 | 03/04/2018 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2018-55-36 | 19/03/2018 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2018-32-36 | 14/02/2018 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2018-4-36 | 05/01/2018 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2017-73-36 | 18/04/2017 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2016-166-36 | 31/08/2016 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2015-156-36 | 18/08/2015 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2015-156-36 | 18/08/2015 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2015-141-36 | 28/07/2015 | Pontevedra | Descargar |