LOGISTIC PACKAGING RETURN IBERICA SA
Cambio de denominación social
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
Fecha
|
Nombre
|
|
---|---|---|
Nombramiento: 16/03/2010 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor |
Cese: 10/02/2010 | GOUBE XAVIER GASTON MARIA |
Apoderado |
Nombramiento: 10/02/2010 | BENAZZO FABIO |
Apoderado |
Nombramiento: 10/02/2010 | ROLLAND FRANCOIS |
Apoderado |
Nombramiento: 10/02/2010 | WOLF TILO TORSTEN WIGAND |
Apoderado |
Nombramiento: 10/02/2010 | GOUBE XAVIER GASTON MARIA |
Apoderado |
Nombramiento: 10/02/2010 | GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE |
Apoderado |
Nombramiento: 06/11/2009 | GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE |
Consejero |
Nombramiento: 06/11/2009 | CARABE ALVAREZ GERMAN |
Consejero |
Nombramiento: 06/11/2009 | GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE |
Apoderado |
Nombramiento: 06/11/2009 | CARABE ALVAREZ GERMAN |
Apoderado |
Nombramiento: 25/03/2009 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor |
Nombramiento: 25/03/2009 | REMANE AMADEU ANIFO ABDUL |
Consejero |
Cese: 28/01/2009 | LEMAITRE THIERRY |
Apoderado |
Cese: 22/01/2009 | LEMAITRE THIERRY |
Consejero |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por LOGISTIC PACKAGING RETURN IBERICA SA
16/03/2010 Detalles del anuncio (110642) Datos registrales: T 26156 , F 77, S 8, H M 235181, I/A 47 ( 4.03.10).
- Reelecciones
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
- Cambio de denominación social
LA PALETTE ROUGE IBERICA SA.
10/02/2010 Detalles del anuncio (56739) Datos registrales: T 26156 , F 75, S 8, H M 235181, I/A 46 (29.01.10).
- Revocaciones
Apoderado: GOUBE XAVIER GASTON MARIA.
- Nombramientos
Apoderado: BENAZZO FABIO;ROLLAND FRANCOIS;WOLF TILO TORSTEN WIGAND;GOUBE XAVIER GASTON MARIA;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE.
- Otros Conceptos
Se cambia el domicilio de la sucursal italiana LOGISTIC PACKAGING RETURN IBERCIA, S. A., SUCURSAL EN ITALIA, a Via Einaudi número 22, Landriano (PV), Italia.
06/11/2009 Detalles del anuncio (465806) Datos registrales: T 26156 , F 74, S 8, H M 235181, I/A 44 (26.10.09).
- Nombramientos
Consejero: GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE.
- Reelecciones
Consejero: CARABE ALVAREZ GERMAN.
06/11/2009 Detalles del anuncio (465807) Datos registrales: T 26156 , F 74, S 8, H M 235181, I/A 45 (26.10.09).
- Nombramientos
Apoderado: GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE;CARABE ALVAREZ GERMAN.
25/03/2009 Detalles del anuncio (146812) Datos registrales: T 26156 , F 74, S 8, H M 235181, I/A 43 (13.03.09).
- Reelecciones
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: REMANE AMADEU ANIFO ABDUL.
19/02/2009 Detalles del anuncio (72757)
- Depósitos de cuentas anuales
(Febrero de 2009) Año: 2008
28/01/2009 Detalles del anuncio (46519) Datos registrales: T 26156 , F 74, S 8, H M 235181, I/A 42 (16.01.09).
- Revocaciones
Apoderado: LEMAITRE THIERRY.
22/01/2009 Detalles del anuncio (35265) Datos registrales: T 14268 , F 225, S 8, H M 235181, I/A 41 (13.01.09).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: LEMAITRE THIERRY.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 8
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
---|---|---|---|
BORME-A-2010-51-28 | 16/03/2010 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2010-27-28 | 10/02/2010 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2009-213-28 | 06/11/2009 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2009-213-28 | 06/11/2009 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2009-57-28 | 25/03/2009 | Madrid | Descargar |
BORME-B-2009-34-28 | 19/02/2009 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2009-18-28 | 28/01/2009 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2009-14-28 | 22/01/2009 | Madrid | Descargar |