INSPIRIT CLOUD SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 07/08/2019 | DIDAC SHI SUN LEE SING |
Consejero |
| Cese: 07/08/2019 | CARULLA FONT LLUIS |
Consejero |
| Cese: 07/08/2019 | CARULLA RUIZ ADRIA |
Consejero |
| Cese: 07/08/2019 | CARULLA FONT LLUIS |
Presidente |
| Cese: 07/08/2019 | DIDAC SHI SUN LEE SING |
Consejero delegado |
| Cese: 07/08/2019 | CARULLA FONT MARIA |
Consejero |
| Cese: 07/08/2019 | VILLA SANCHEZ DAVID |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 07/08/2019 | FACTOR CONSULTING HSING SL |
Administrador único |
| Nombramiento: 07/08/2019 | DIDAC SHI SUN LEE HSING |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 03/09/2018 | PANIZO COLOM LOURDES |
Apoderado |
| Cese: 27/03/2018 | SANDRIGHAM SL |
Consejero |
| Cese: 27/03/2018 | ELIAS DE GISPERT IGNASI |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 06/03/2017 | CARULLA RUIZ ADRIA |
Secretario |
| Nombramiento: 06/03/2017 | VILLA SANCHEZ DAVID |
Secretario no consejero |
| Cese: 20/05/2015 | DAMPER TRUST SL |
Consejero |
| Cese: 20/05/2015 | CIERCO NOGUER RAMON |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 08/03/2013 | VELASCO LUQUE ROQUE |
Apoderado |
| Nombramiento: 08/03/2013 | VELASCO LUQUE ROQUE |
Apoderado |
| Nombramiento: 09/03/2012 | SANDRIGHAM SL |
Consejero |
| Nombramiento: 09/03/2012 | ELIAS DE GISPERT IGNASI |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 09/03/2012 | CARULLA FONT MARIA |
Consejero |
| Nombramiento: 27/01/2012 | DAMPER TRUST SL |
Consejero |
| Nombramiento: 27/01/2012 | CIERCO NOGUER RAMON |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por INSPIRIT CLOUD SL
27/09/2019 Detalles del anuncio (404306) Datos registrales: T 42540 , F 28, S 8, H B 409162, I/A 43 (20.09.19).
- Cambio de domicilio social
AV DIAGONAL NUM.640 P.6-E (BARCELONA).
07/08/2019 Detalles del anuncio (345585) Datos registrales: T 42540 , F 27, S 8, H B 409162, I/A 42 (31.07.19).
- Revocaciones
CONSEJERO: DIDAC SHI SUN LEE SING;CARULLA FONT LLUIS;CARULLA RUIZ ADRIA. PRESIDENTE: CARULLA FONT LLUIS. CONS. DELEG.: DIDAC SHI SUN LEE SING. CONSEJERO: CARULLA FONT MARIA. SECR.NO CONS: VILLA SANCHEZ DAVID.
- Nombramientos
ADM.UNICO: FACTOR CONSULTING HSING SL. REPR.143 RRM: DIDAC SHI SUN LEE HSING.
- Modificaciones Estatutarias
MODIFICACION DEL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CONVOCATORIA.
03/09/2018 Detalles del anuncio (359565) Datos registrales: T 42540 , F 27, S 8, H B 409162, I/A 41 (27.08.18).
- Revocaciones
APODERADO: PANIZO COLOM LOURDES.
27/03/2018 Detalles del anuncio (138825) Datos registrales: T 42540 , F 27, S 8, H B 409162, I/A 40 (19.03.18).
- Revocaciones
CONSEJERO: SANDRIGHAM SL. REPR.143 RRM: ELIAS DE GISPERT IGNASI.
06/03/2017 Detalles del anuncio (104661) Datos registrales: T 42540 , F 27, S 8, H B 409162, I/A 39 (27.02.17).
- Revocaciones
SECRETARIO: CARULLA RUIZ ADRIA.
- Nombramientos
SECR.NO CONS: VILLA SANCHEZ DAVID.
20/05/2015 Detalles del anuncio (201940) Datos registrales: T 42540 , F 27, S 8, H B 409162, I/A 38 (12.05.15).
- Revocaciones
CONSEJERO: DAMPER TRUST SL. REPR.143 RRM: CIERCO NOGUER RAMON.
22/10/2014 Detalles del anuncio (422350) Datos registrales: T 42540 , F 26, S 8, H B 409162, I/A 37 (14.10.14).
- Cambio de domicilio social
AV DIAGONAL Num.409 P.6 PTA.B (BARCELONA).
04/06/2014 Detalles del anuncio (233856) Datos registrales: T 42540 , F 26, S 8, H B 409162, I/A 36 (26.05.14).
- Ampliación de Capital
Capital: 22.753,86 Euros. Resultante Suscrito: 506.222,30 Euros.
08/03/2013 Detalles del anuncio (115264) Datos registrales: T 42540 , F 24, S 8, H B 409162, I/A 35 (27.02.13).
- Revocaciones
APODERADO: VELASCO LUQUE ROQUE.
- Nombramientos
APODERADO: VELASCO LUQUE ROQUE.
21/11/2012 Detalles del anuncio (477378) Datos registrales: T 42540 , F 23, S 8, H B 409162, I/A 34 ( 9.11.12).
- Ampliación de Capital
Capital: 45.501,71 Euros. Resultante Suscrito: 483.468,44 Euros.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 14
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2019-186-08 | 27/09/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-150-08 | 07/08/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-169-08 | 03/09/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-61-08 | 27/03/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2017-45-08 | 06/03/2017 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-93-08 | 20/05/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-202-08 | 22/10/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-104-08 | 04/06/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-47-08 | 08/03/2013 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2012-223-08 | 21/11/2012 | Barcelona | Descargar |