FLORES ALFINDEN SL

Extinta

PASEO J.M& ARIZMENDIARRIETA, Nº 4. (MONDRAGON).
-
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 06/07/2012

MARTINEZ LOPEZ ANGEL

Apoderado
Cese: 03/03/2011

CONSTRUCCIONES JUAN BAUTISTA FLORES S A

Consejero
Cese: 03/03/2011

CAJA LABORAL POPULAR SOCIEDAD COOP DE CREDITO LIM

Consejero
Cese: 03/03/2011

FOMENCLAR S L

Consejero
Cese: 03/03/2011

FOMENCLAR S L

Presidente
Cese: 03/03/2011

ORBEA CELAYA ADRIAN

Secretario no consejero
Nombramiento: 03/03/2011

FOMENCLAR SL

Administrador único
Cese: 16/06/2010

AGUADO FLORES IGNACIO

Apoderado
Cese: 16/06/2010

ARISTONDO BUSTINDUY RICARDO

Apoderado
Cese: 16/06/2010

FLORES GONZALEZ CONCEPCION

Apoderado
Cese: 16/06/2010

GOITIANDIA GORROTXATEGUI JESUS MARIA

Apoderado
Cese: 16/06/2010

GONZALEZ BARRIOS JOSE ANTONIO

Apoderado
Cese: 16/06/2010

MADINABEITIA DEL RIO PEDRO

Apoderado
Cese: 16/06/2010

SANZ GAMBOA MANUEL

Apoderado
Cese: 16/06/2010

VELASCO LINARES FRANCISCO

Apoderado
Cese: 16/06/2010

AGUADO FLORES IGNACIO

Apoderado
Cese: 16/06/2010

ARROYO SANCHEZ IKER

Apoderado
Cese: 16/06/2010

FLORES GONZALEZ CONCEPCION

Apoderado
Cese: 16/06/2010

GONZALEZ BARRIOS JOSE ANTONIO

Apoderado
Cese: 16/06/2010

MADINABEITIA DEL RIO PEDRO

Apoderado
Cese: 16/06/2010

SANZ GAMBOA MANUEL

Apoderado
Cese: 16/06/2010

VELASCO LINARES FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 16/06/2010

MADINABEITIA DEL RIO PEDRO

Apoderado
Nombramiento: 16/06/2010

ARROYO SANCHEZ IKER

Apoderado
Nombramiento: 16/06/2010

VELASCO LINARES FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 16/06/2010

IBAÑEZ CASTILLERO JUAN CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 16/06/2010

BENAVENTE MIGUEL JUAN CARLOS

Apoderado
Cese: 31/12/2009

CONSTRUCCIONES JUAN BAUTISTA FLORES S A

Presidente
Nombramiento: 31/12/2009

FOMENCLAR S L

Presidente
Nombramiento: 26/11/2009

FLORES GONZALEZ CONCEPCION

Apoderado
Nombramiento: 26/11/2009

GONZALEZ BARRIOS JOSE ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 26/11/2009

AGUADO FLORES IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 26/11/2009

MADINABEITIA DEL RIO PEDRO

Apoderado
Nombramiento: 26/11/2009

SANZ GAMBOA MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 26/11/2009

ARROYO SANCHEZ IKER

Apoderado
Nombramiento: 26/11/2009

VELASCO LINARES FRANCISCO

Apoderado
Cese: 26/11/2009

LAGUN ARO ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA

Consejero
Nombramiento: 26/11/2009

FOMENCLAR S L

Consejero
Nombramiento: 24/08/2009

AGUADO FLORES IGNACIO

Consejero
Cese: 24/08/2009

AGUADO FLORES IGNACIO

Consejero
Cese: 24/08/2009

ARISTONDO BUSTINDUY RICARDO

Apoderado
Cese: 24/08/2009

CAMARA BAZTAN PABLO

Apoderado
Cese: 24/08/2009

FLORES GONZALEZ CONCEPCION

Apoderado
Cese: 24/08/2009

GOITIANDIA GORROTXATEGUI JESUS MARIA

Apoderado
Cese: 24/08/2009

MADINABEITIA DEL RIO PEDRO

Apoderado
Cese: 24/08/2009

SANZ GAMBOA MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

GONZALEZ BARRIOS JOSE ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

AGUADO FLORES IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

GOITIANDIA GORROTXATEGUI JESUS MARIA

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

ARISTONDO BUSTINDUY RICARDO

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

MADINABEITIA DEL RIO PEDRO

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

SANZ GAMBOA MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

VELASCO LINARES FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

FLORES GONZALEZ CONCEPCION

Apoderado
Cese: 06/07/2009

CAMARA BAZTAN PABLO

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por FLORES ALFINDEN SL

12/08/2014 Detalles del anuncio (330067) Datos registrales: T 2638 , F 155, S 8, H SS 36163, I/A 3 (21.07.14).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

11/03/2014 Detalles del anuncio (109958) Datos registrales: T 2638 , F 106, S 8, H SS 36163, I/A 1 ( 4.03.14).

  • Cambio de domicilio social

    PASEO J.M& ARIZMENDIARRIETA, Nº 4. (MONDRAGON).

06/07/2012 Detalles del anuncio (286994) Datos registrales: T 1237 , F 154, S 8, H NA 24710, I/A 18 (26.06.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: MARTINEZ LOPEZ ANGEL.

09/08/2011 Detalles del anuncio (266389)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2011) Año: 2010

04/07/2011 Detalles del anuncio (282439) Datos registrales: T 1237 , F 154, S 8, H NA 24710, I/A 17 (21.06.11).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 6.122.450,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 3.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 6 (Capital).

03/03/2011 Detalles del anuncio (97817) Datos registrales: T 1237 , F 153, S 8, H NA 24710, I/A 16 (21.02.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: CONSTRUCCIONES JUAN BAUTISTA FLORES S. A.;CAJA LABORAL POPULAR SOCIEDAD COOP. DE CREDITO LIM;FOMENCLAR S. L. Presidente: FOMENCLAR S. L. SecreNoConsj: ORBEA CELAYA ADRIAN.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: FOMENCLAR S.L.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.ARTICULO 7º.- La participación confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los derechos que le reconoce la Ley y estos Estatutos. Las participaciones sociales son indivisibles y su transmisión deberá constar en documento público.. ARTICULO 8º.- Las participaciones sociales.

  • Otros Conceptos

    Designado don Pedro Madinabeitia Del Río representante físico del Administrador Unico nombrado.

09/09/2010 Detalles del anuncio (508104)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2010) Año: 2009

16/06/2010 Detalles del anuncio (240606) Datos registrales: T 1237 , F 151, S 8, H NA024710, I/A00015 ( 4.06.10).

  • Revocaciones

    Apoderado: AGUADO FLORES IGNACIO;ARISTONDO BUSTINDUY RICARDO;FLORES GONZALEZ CONCEPCION;GOITIANDIA GORROTXATEGUI JESUS MARIA;GONZALEZ BARRIOS JOSE ANTONIO;MADINABEITIA DEL RIO PEDRO;SANZ GAMBOA MANUEL;VELASCO LINARES FRANCISCO;AGUADO FLORES IGNACIO;ARROYO SANCHEZ IKER;FLORES GONZALEZ CONCEPCION;GONZALEZ BARRIOS JOSE ANTONIO;MADINABEITIA DEL RIO PEDRO;SANZ GAMBOA MANUEL;VELASCO LINARES FRANCISCO.

  • Nombramientos

    Apoderado: MADINABEITIA DEL RIO PEDRO;ARROYO SANCHEZ IKER;VELASCO LINARES FRANCISCO;IBAÑEZ CASTILLERO JUAN CARLOS;BENAVENTE MIGUEL JUAN CARLOS.

15/06/2010 Detalles del anuncio (238425) Datos registrales: T 1237 , F 151, S 8, H NA024710, I/A00014 ( 4.06.10).

  • Cambio de domicilio social

    CALLE ARCADIO MARIA LARRAONA, nº 1 1º (PAMPLONA).

10/02/2010 Detalles del anuncio (89147)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Enero de 2010) Año: 2008

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 18

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2014-152-20 12/08/2014 Gipuzkoa Descargar
BORME-A-2014-48-20 11/03/2014 Gipuzkoa Descargar
BORME-A-2012-128-31 06/07/2012 Navarra Descargar
BORME-B-2011-151-31 09/08/2011 Navarra Descargar
BORME-A-2011-126-31 04/07/2011 Navarra Descargar
BORME-A-2011-43-31 03/03/2011 Navarra Descargar
BORME-B-2010-174-31 09/09/2010 Navarra Descargar
BORME-A-2010-113-31 16/06/2010 Navarra Descargar
BORME-A-2010-112-31 15/06/2010 Navarra Descargar
BORME-B-2010-27-31 10/02/2010 Navarra Descargar