EBOX NETWORKS SL

Activa

CL VALENCIA Num.333 P.BJ (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 04/05/2016

BEFACTORY NETWORKS SL

Consejero
Cese: 04/05/2016

OLIVE FERNANDEZ GERARD

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 04/05/2016

SORLI RACIOPPI MARC

Consejero
Cese: 04/05/2016

BEFACTORY NETWORKS SL

Presidente
Cese: 04/05/2016

SORLI RACIOPPI MARC

Consejero delegado
Cese: 04/05/2016

SANTISTEBAN MORENO INMACULADA

Consejero
Cese: 04/05/2016

MORENO ESPEJO DAVID

Secretario no consejero
Cese: 04/05/2016

ANTAI BUSINESS ANGELS SL

Consejero
Cese: 04/05/2016

ANTAI BUSINESS ANGELS SL

Vicepresidente
Cese: 04/05/2016

VICENTE VERDOY MIGUEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 04/05/2016

SANTACANA SOLE JOSEP

Consejero
Nombramiento: 04/05/2016

SORLI RACIOPPI MARC

Administrador único
Nombramiento: 11/04/2016

RACIOPPI MICIANO LAURA

Apoderado solidario
Nombramiento: 17/08/2015

ANTAI BUSINESS ANGELS SL

Consejero
Nombramiento: 17/08/2015

ANTAI BUSINESS ANGELS SL

Vicepresidente
Nombramiento: 17/08/2015

VICENTE VERDOY MIGUEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 11/06/2015

JORDANA SOLDEVILA MARC

Consejero
Cese: 11/06/2015

JORDANA SOLDEVILA MARC

Secretario
Nombramiento: 11/06/2015

MORENO ESPEJO DAVID

Secretario no consejero
Cese: 11/06/2015

CABIEDES AND PARTNERS SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO

Consejero
Cese: 11/06/2015

MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES LUIS ANTONIO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 20/11/2013

GIMENO MARQUINA MIGUEL ANGEL

Consejero
Nombramiento: 20/11/2013

SANTISTEBAN MORENO INMACULADA

Consejero
Cese: 26/02/2013

BEFACTORY NETWORKS SL

Administrador único
Cese: 26/02/2013

OLIVE FERNANDEZ GERARD

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 26/02/2013

BEFACTORY NETWORKS SL

Consejero
Nombramiento: 26/02/2013

OLIVE FERNANDEZ GERARD

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 26/02/2013

JORDANA SOLDEVILA MARC

Consejero
Nombramiento: 26/02/2013

SORLI RACIOPPI MARC

Consejero
Nombramiento: 26/02/2013

GIMENO MARQUINA MIGUEL ANGEL

Consejero
Nombramiento: 26/02/2013

CABIEDES AND PARTNERS SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO

Consejero
Nombramiento: 26/02/2013

MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES LUIS ANTONIO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 26/02/2013

BEFACTORY NETWORKS SL

Presidente
Nombramiento: 26/02/2013

JORDANA SOLDEVILA MARC

Secretario
Nombramiento: 26/02/2013

SORLI RACIOPPI MARC

Consejero delegado
Nombramiento: 20/06/2012

BEFACTORY NETWORKS SL

Administrador único
Nombramiento: 20/06/2012

OLIVE FERNANDEZ GERARD

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por EBOX NETWORKS SL

20/09/2024 Detalles del anuncio (405072) Datos registrales: S 8 , H B 427532, I/A 18 (13.09.24).

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 8 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 45/2023, AUTO FIRME DE FECHA 21/09/2023, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO;AUTO FIRME 20/11/2023: CONCLUSION DE CONCURSO Y CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL.

30/11/2022 Detalles del anuncio (525333) Datos registrales: T 45859 , F 221, S 8, H B 427532, I/A A (22.11.22).

  • Otros Conceptos

    ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO.

21/06/2017 Detalles del anuncio (256036) Datos registrales: T 45859 , F 216, S 8, H B 427532, I/A 17 (13.06.17).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 299.999,99 Euros. Resultante Suscrito: 764.694,10 Euros.

02/06/2017 Detalles del anuncio (229916) Datos registrales: T 45859 , F 213, S 8, H B 427532, I/A 16 (25.05.17).

  • Otros Conceptos

    RECTIFICADA LA INSCRIPCION 12, EN CUANTO A LA CIFRA DE CAPITAL AUMENTADO, SIENDO LA CORRECTA 68.750,99 EUROS Y EL CAPITAL RESULTANTE SUSCRITO Y DESEMBOLSADO DE 464.694,11 EUROS.

02/06/2017 Detalles del anuncio (229915) Datos registrales: T 43594 , F 210, S 8, H B 427532, I/A 15 (25.05.17).

  • Otros Conceptos

    RECTIFICADA LA INSCRIPCION 11, EN CUANTO A LA CIFRA DE CAPITAL AUMENTADO, SIENDO LA CORRECTA 72.761,26 EUROS Y EL CAPITAL RESULTANTE SUSCRITO Y DESEMBOLSADO DE 395.943,12 EUROS.

04/05/2016 Detalles del anuncio (191322) Datos registrales: T 43594 , F 210, S 8, H B 427532, I/A 14 (26.04.16).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: BEFACTORY NETWORKS SL. REPR.143 RRM: OLIVE FERNANDEZ GERARD. CONSEJERO: SORLI RACIOPPI MARC. PRESIDENTE: BEFACTORY NETWORKS SL. CONS. DELEG.: SORLI RACIOPPI MARC. CONSEJERO: SANTISTEBAN MORENO INMACULADA. SECR.NO CONS: MORENO ESPEJO DAVID. CONSEJERO: ANTAI BUSINESS ANGELS SL. VICEPRESIDEN: ANTAI BUSINESS ANGELS SL. REPR.143 RRM: VICENTE VERDOY MIGUEL. CONSEJERO: SANTACANA SOLE JOSEP.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: SORLI RACIOPPI MARC.

11/04/2016 Detalles del anuncio (157061) Datos registrales: T 43594 , F 209, S 8, H B 427532, I/A 13 ( 4.04.16).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: RACIOPPI MICIANO LAURA.

29/12/2015 Detalles del anuncio (526818) Datos registrales: T 43594 , F 207, S 8, H B 427532, I/A 12 ( 6.08.15).

  • Fe de erratas

    En el BORME no.155/2015 y con referencia 339929 POR OMISION DEL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE JOSEP SANTACANA SOLE.

17/08/2015 Detalles del anuncio (339929) Datos registrales: T 43594 , F 207, S 8, H B 427532, I/A 12 ( 6.08.15).

  • Nombramientos

    CONSEJERO: ANTAI BUSINESS ANGELS SL. VICEPRESIDEN: ANTAI BUSINESS ANGELS SL. REPR.143 RRM: VICENTE VERDOY MIGUEL.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 70.601,58 Euros. Resultante Suscrito: 467.744,31 Euros.

11/06/2015 Detalles del anuncio (234974) Datos registrales: T 43594 , F 204, S 8, H B 427532, I/A 11 ( 3.06.15).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: JORDANA SOLDEVILA MARC. SECRETARIO: JORDANA SOLDEVILA MARC.

  • Nombramientos

    SECR.NO CONS: MORENO ESPEJO DAVID.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 73.960,87 Euros. Resultante Suscrito: 397.142,73 Euros.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2024-182-08 20/09/2024 Barcelona Descargar
BORME-A-2022-228-08 30/11/2022 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-116-08 21/06/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-103-08 02/06/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-103-08 02/06/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-84-08 04/05/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-68-08 11/04/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-247-08 29/12/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-155-08 17/08/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-108-08 11/06/2015 Barcelona Descargar