DEMAG CRANES & COMPONENTS SA

Extinta

CALLE BULEVAR DE BUENOS AIRES, S/N - PG IND CAMPORROSO
 Alcalá de Henares, Madrid  (28806)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 14/05/2018

CAÑIBANO RAMOS ALFREDO

Apoderado
Cese: 14/05/2018

RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE

Apoderado
Cese: 14/05/2018

CAÑIBANO RAMOS ALFREDO

Apoderado
Cese: 14/05/2018

RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE

Apoderado
Cese: 14/05/2018

GRAND NICOLAS BRUNO DANIEL

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 14/05/2018

CAÑIBANO RAMOS ALFREDO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 14/05/2018

RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 14/05/2018

GARCIA COSTALES DAVID

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 14/05/2018

MARTINEZ BERNARDO FELIX MARIANO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 14/05/2018

MELLI ORTEGA RODRIGO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 14/05/2018

BENNETT MARK

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 14/05/2018

RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE

Apoderado
Nombramiento: 14/05/2018

NUÑEZ ARENAS VILLARES ANGEL

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 14/05/2018

RIUS CULI MONTSERRAT

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/05/2018

BLANQUEZ MARTINEZ MANUEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/05/2018

AYERZA IZAGUIRRE IÑAKI

Apoderado solidario
Nombramiento: 14/05/2018

FAJA SANCHEZ ROGER

Apoderado solidario
Nombramiento: 14/05/2018

BLANQUEZ MARTINEZ MANUEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/05/2018

RIUS CULI MONTSERRAT

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/05/2018

NUÑEZ ARENAS VILLARES ANGEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/05/2018

RIUS CULI MONTSERRAT

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 14/05/2018

BLANQUEZ MARTINEZ MANUEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/05/2018

NUÑEZ ARENAS VILLARES ANGEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 06/04/2018

ERNST & YOUNG SL

Auditor
Cese: 19/12/2017

BRADLEY KEVIN-PATRICK

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/12/2017

POITSALO SIRPA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 18/12/2017

OTTOLA TEO JUHANI

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 19/06/2017

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 12/06/2017

BELZUZ FERNANDEZ ENRIQUE

Secretario no consejero
Cese: 12/06/2017

COHEN ERIC I

Consejero
Cese: 12/06/2017

BRADLEY KEVIN- PATRICK

Consejero
Cese: 12/06/2017

FILIPOV STOYAN

Consejero
Cese: 12/06/2017

FILIPOV STOYAN

Presidente
Cese: 12/06/2017

COHEN ERIC I

Apoderado mancomunado
Cese: 12/06/2017

BRADLEY KEVIN PATRICK

Apoderado mancomunado
Cese: 12/06/2017

COHEN ERIC I

Apoderado
Cese: 12/06/2017

FILIPOV STOYAN

Apoderado
Cese: 12/06/2017

BRADLEY KEVIN-PATRICK

Apoderado
Cese: 12/06/2017

COHEN ERIC I

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 12/06/2017

FILIPOV STOYAN

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 12/06/2017

SMITH GRAHAM JOHN

Apoderado
Nombramiento: 12/06/2017

GIL ROIG RAMON

Secretario no consejero
Nombramiento: 12/06/2017

LEHTINEN AKU JUHANI

Consejero
Nombramiento: 12/06/2017

NUÑEZ ARENAS VILLARES ANGEL

Consejero
Nombramiento: 12/06/2017

MYNTTI TOMAS

Consejero
Nombramiento: 12/06/2017

MYNTTI TOMAS

Presidente
Nombramiento: 12/06/2017

MYNTTI TOMAS

Consejero delegado
Cese: 22/04/2016

MATA MONTES IGNACIO

Apoderado
Cese: 22/04/2016

DIAZ TRUJILLO FERNANDO

Apoderado
Cese: 22/04/2016

LLAGOSTERA WIELER ESTEBAN

Apoderado
Cese: 22/04/2016

DE ARCOS PEREZ GEMMA

Apoderado
Cese: 22/04/2016

LEOPOLD BERND

Apoderado
Nombramiento: 01/04/2016

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 08/03/2016

RODETIS GREGORY ALEXANDER

Apoderado
Nombramiento: 22/02/2016

BENNETT MARK

Apoderado mancomunado solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por DEMAG CRANES & COMPONENTS SA

18/10/2018 Detalles del anuncio (417136) Datos registrales: T 34342 , F 134, S 8, H M 308170, I/A 55 (10.10.18).

  • Otros Conceptos

    CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL.

  • Extinción

13/09/2018 Detalles del anuncio (375885) Datos registrales: T 34342 , F 134, S 8, H M 308170, I/A 54m ( 4.09.18).

  • Otros Conceptos

    Nota marginal de cierre provisional de la hoja registral por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el art. 231 RRM.

02/07/2018 Detalles del anuncio (275835) Datos registrales: T 17859 , F 78, S 8, H M 308170, I/A 1-M (25.06.18).

  • Otros Conceptos

    En fecha 25 de Junio de 2018, ha sido depositado el proyecto de fusión de las sociedades KONECRANES IBERICA SL, CIF B-60442530, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona; y la sociedad DEMAG CRANES & COMPONENTS SA, CIF A-83398586, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

14/05/2018 Detalles del anuncio (204631) Datos registrales: T 34342 , F 132, S 8, H M 308170, I/A 54 ( 7.05.18).

  • Revocaciones

    Apoderado: CAÑIBANO RAMOS ALFREDO;RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE;CAÑIBANO RAMOS ALFREDO;RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE. Apo.Man.Soli: GRAND NICOLAS BRUNO DANIEL;CAÑIBANO RAMOS ALFREDO;RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE;GARCIA COSTALES DAVID;MARTINEZ BERNARDO FELIX MARIANO;MELLI ORTEGA RODRIGO;BENNETT MARK.

  • Nombramientos

    Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE. Apo.Man.Soli: NUÑEZ ARENAS VILLARES ANGEL. Apo.Manc.: RIUS CULI MONTSERRAT;BLANQUEZ MARTINEZ MANUEL. Apo.Sol.: AYERZA IZAGUIRRE IÑAKI;FAJA SANCHEZ ROGER. Apo.Manc.: BLANQUEZ MARTINEZ MANUEL;RIUS CULI MONTSERRAT;NUÑEZ ARENAS VILLARES ANGEL. Apo.Man.Soli: RIUS CULI MONTSERRAT. Apo.Manc.: BLANQUEZ MARTINEZ MANUEL;NUÑEZ ARENAS VILLARES ANGEL.

06/04/2018 Detalles del anuncio (153978) Datos registrales: T 34342 , F 132, S 8, H M 308170, I/A 53 (26.03.18).

  • Nombramientos

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.

19/12/2017 Detalles del anuncio (494695) Datos registrales: T 34342 , F 132, S 8, H M 308170, I/A 52 (11.12.17).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: BRADLEY KEVIN-PATRICK.

18/12/2017 Detalles del anuncio (492814) Datos registrales: T 34342 , F 131, S 8, H M 308170, I/A 51 (11.12.17).

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: POITSALO SIRPA;OTTOLA TEO JUHANI.

20/06/2017 Detalles del anuncio (254760) Datos registrales: T 34342 , F 131, S 8, H M 308170, I/A 50 (13.06.17).

  • Sociedad Unipersonal

    KONECRANES IBERICA SLU.

19/06/2017 Detalles del anuncio (252632) Datos registrales: T 34342 , F 130, S 8, H M 308170, I/A 49 ( 9.06.17).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

12/06/2017 Detalles del anuncio (242042) Datos registrales: T 34342 , F 130, S 8, H M 308170, I/A 48 ( 2.06.17).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: BELZUZ FERNANDEZ ENRIQUE. Consejero: COHEN ERIC I;BRADLEY KEVIN- PATRICK;FILIPOV STOYAN. Presidente: FILIPOV STOYAN.

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: COHEN ERIC I;BRADLEY KEVIN PATRICK. Apoderado: COHEN ERIC I;FILIPOV STOYAN;BRADLEY KEVIN-PATRICK. Apo.Man.Soli: COHEN ERIC I;FILIPOV STOYAN. Apoderado: SMITH GRAHAM JOHN.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: GIL ROIG RAMON. Consejero: LEHTINEN AKU JUHANI;NUÑEZ ARENAS VILLARES ANGEL;MYNTTI TOMAS. Presidente: MYNTTI TOMAS. Con.Delegado: MYNTTI TOMAS.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 39

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2018-201-28 18/10/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-177-28 13/09/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-125-28 02/07/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-91-28 14/05/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-67-28 06/04/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-239-28 19/12/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-238-28 18/12/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-115-28 20/06/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-114-28 19/06/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-109-28 12/06/2017 Madrid Descargar