CUATOR SA

Situación Concursal

CALLE NUMERO TRES (BO CARBONAIRE) (POL. INDUSTRIAL CARDAMAY), 5 - 6
 Vall d'Uixó, la, Castellón/Castelló  (12600)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 17/05/2021

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero
Cese: 17/05/2021

ROS CAMARELLES BENITO

Consejero
Cese: 17/05/2021

RUBIO GARCES JOSE

Consejero
Cese: 17/05/2021

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero delegado
Cese: 17/05/2021

ROS CAMARELLES BENITO

Secretario
Cese: 17/05/2021

RUBIO GARCES JOSE

Presidente
Nombramiento: 17/05/2021

RUBIO GARCES JOSE

Consejero
Nombramiento: 17/05/2021

RUBIO GARCES JOSE

Presidente
Nombramiento: 17/05/2021

ROS CAMARELLES BENITO

Consejero
Nombramiento: 17/05/2021

ROS CAMARELLES BENITO

Secretario
Nombramiento: 17/05/2021

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 17/05/2021

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero delegado
Nombramiento: 07/08/2018

DE LA FUENTE GONZALEZ PEDRO ELIAS

Apoderado
Cese: 03/11/2014

RUBIO GARCES JOSE

Consejero
Cese: 03/11/2014

ROS CAMARELLES BENITO

Consejero
Cese: 03/11/2014

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero
Cese: 03/11/2014

RUBIO GARCES JOSE

Presidente
Cese: 03/11/2014

ROS CAMARELLES BENITO

Secretario
Cese: 03/11/2014

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero delegado
Nombramiento: 03/11/2014

RUBIO GARCES JOSE

Consejero
Nombramiento: 03/11/2014

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 03/11/2014

ROS CAMARELLES BENITO

Consejero
Nombramiento: 03/11/2014

RUBIO GARCES JOSE

Presidente
Nombramiento: 03/11/2014

ROS CAMARELLES BENITO

Secretario
Nombramiento: 03/11/2014

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero delegado
Nombramiento: 15/11/2013

MANGRIÑAN LAZARO ANTONIO

Apoderado
Cese: 20/12/2011

RUBIO GARCES JOSE

Apoderado mancomunado
Cese: 20/12/2011

ROIG RUBIO ROBERTO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 02/02/2011

RUBIO PARRA JOSE

Apoderado
Cese: 17/06/2009

RUBIO GARCES JOSE

Consejero
Cese: 17/06/2009

RUBIO GARCES JOSE

Presidente
Cese: 17/06/2009

ROIG RUBIO ROBERTO

Consejero
Cese: 17/06/2009

ROIG RUBIO ROBERTO

Secretario
Cese: 17/06/2009

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero
Cese: 17/06/2009

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero delegado
Cese: 17/06/2009

ROS CAMARELLES BENITO

Consejero
Cese: 17/06/2009

BOVAIRA FORNER LEOPOLDO

Consejero
Nombramiento: 17/06/2009

RUBIO GARCES JOSE

Consejero
Nombramiento: 17/06/2009

ROS CAMARELLES BENITO

Consejero
Nombramiento: 17/06/2009

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 17/06/2009

RUBIO GARCES JOSE

Presidente
Nombramiento: 17/06/2009

ROS CAMARELLES BENITO

Secretario
Nombramiento: 17/06/2009

MANGRIÑAN FORNER ANTONIO

Consejero delegado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por CUATOR SA

10/08/2023 Detalles del anuncio (362192) Datos registrales: T 657, L 224, F 214, S 8, H CS 6080, I/A 20 ( 2.08.23).

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 000367/2023. FIRME: Si, Fecha de resolución 12/05/2023. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA. Juez: FRANCISCO GIL MONZO.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 000367/2023. Fecha de resolución 12/05/2023. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA. Juez: FRANCISCO GIL MONZO. Administrador Concursal. Fecha 12/05/2023, NIF/CIF B12464756. CASTELLANO ASESORES CONSULTORES SL.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 000367/2023. FIRME: Si, Fecha de resolución 12/05/2023. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA. Juez: FRANCISCO GIL MONZO.

17/05/2021 Detalles del anuncio (231364) Datos registrales: T 657, L 224, F 214, S 8, H CS 6080, I/A 19 (10.05.21).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MANGRIÑAN FORNER ANTONIO;ROS CAMARELLES BENITO;RUBIO GARCES JOSE. Con.Delegado: MANGRIÑAN FORNER ANTONIO. Secretario: ROS CAMARELLES BENITO. Presidente: RUBIO GARCES JOSE.

  • Nombramientos

    Consejero: RUBIO GARCES JOSE. Presidente: RUBIO GARCES JOSE. Consejero: ROS CAMARELLES BENITO. Secretario: ROS CAMARELLES BENITO. Consejero: MANGRIÑAN FORNER ANTONIO. Con.Delegado: MANGRIÑAN FORNER ANTONIO.

07/08/2018 Detalles del anuncio (327087) Datos registrales: T 657, L 224, F 214, S 8, H CS 6080, I/A 18 (27.07.18).

  • Nombramientos

    Apoderado: DE LA FUENTE GONZALEZ PEDRO ELIAS.

03/11/2014 Detalles del anuncio (441855) Datos registrales: T 657, L 224, F 213, S 8, H CS 6080, I/A 17 (24.10.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: RUBIO GARCES JOSE;ROS CAMARELLES BENITO;MANGRIÑAN FORNER ANTONIO. Presidente: RUBIO GARCES JOSE. Secretario: ROS CAMARELLES BENITO. Con.Delegado: MANGRIÑAN FORNER ANTONIO.

  • Nombramientos

    Consejero: RUBIO GARCES JOSE;MANGRIÑAN FORNER ANTONIO;ROS CAMARELLES BENITO. Presidente: RUBIO GARCES JOSE. Secretario: ROS CAMARELLES BENITO. Con.Delegado: MANGRIÑAN FORNER ANTONIO.

15/11/2013 Detalles del anuncio (488073) Datos registrales: T 657, L 224, F 213, S 8, H CS 6080, I/A 16 ( 7.11.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: MANGRIÑAN LAZARO ANTONIO.

20/12/2011 Detalles del anuncio (503667) Datos registrales: T 657, L 224, F 213, S 8, H CS 6080, I/A 15 ( 7.12.11).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: RUBIO GARCES JOSE;ROIG RUBIO ROBERTO.

25/08/2011 Detalles del anuncio (350507)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

02/02/2011 Detalles del anuncio (43915) Datos registrales: T 657, L 224, F 213, S 8, H CS 6080, I/A 14 (24.01.11).

  • Nombramientos

    Apoderado: RUBIO PARRA JOSE.

07/09/2010 Detalles del anuncio (467980)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2010) Año: 2009

18/08/2009 Detalles del anuncio (222167)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2009) Año: 2008

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2023-152-12 10/08/2023 Castellón/Castelló Descargar
BORME-A-2021-91-12 17/05/2021 Castellón/Castelló Descargar
BORME-A-2018-151-12 07/08/2018 Castellón/Castelló Descargar
BORME-A-2014-210-12 03/11/2014 Castellón/Castelló Descargar
BORME-A-2013-219-12 15/11/2013 Castellón/Castelló Descargar
BORME-A-2011-239-12 20/12/2011 Castellón/Castelló Descargar
BORME-B-2011-162-12 25/08/2011 Castellón/Castelló Descargar
BORME-A-2011-22-12 02/02/2011 Castellón/Castelló Descargar
BORME-B-2010-172-12 07/09/2010 Castellón/Castelló Descargar
BORME-B-2009-156-12 18/08/2009 Castellón/Castelló Descargar