CORNING CABLE SYSTEMS SL

Cambio de denominación social

CMNO CERRO DE LOS GAMOS 1 - EDIFICIO 1 PLANTA 1 (POZUELO DE ALARCON).
 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 16/01/2015

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 24/12/2013

KEENAN CHAD A

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 24/12/2013

SINGLOVICS ZSOFIA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 24/12/2013

TRBOVIC GILLIAN

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 24/12/2013

CSUHAJ KATALIN

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 13/06/2013

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 25/01/2013

CHOROSZ GILBERT CLAUDE

Consejero
Cese: 25/01/2013

CHOROSZ GILBERT CLAUDE

Presidente
Cese: 25/01/2013

CHOROSZ GILBERT CLAUDE

Consejero delegado
Nombramiento: 25/01/2013

ECHAHAMIAN CLAUDE

Consejero
Nombramiento: 25/01/2013

ECHAHAMIAN CLAUDE

Presidente
Cese: 25/01/2013

RIUS GARRETA JORGE

Apoderado
Cese: 25/01/2013

RUBIO RODRIGUEZ VIGIL MARIA EUGENIA

Apoderado
Cese: 25/01/2013

MUÑIZ PRIETO MARIA ANGELES

Apoderado
Cese: 25/01/2013

CHOROSZ GILBERT CLAUDE

Apoderado
Cese: 25/01/2013

PINDADO RODRIGUEZ OSCAR

Apoderado
Cese: 25/01/2013

CARLOS GRANJA JOSE

Apoderado
Cese: 25/01/2013

BARTOLOME ASENSIO ELENA

Apoderado
Cese: 25/01/2013

HAMER CHRIS

Apoderado
Cese: 25/01/2013

KULAC TUGCE

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2013

PINDADO RODRIGUEZ OSCAR

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2013

BARTOLOME ASENSIO ELENA

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2013

HAMER CHRIS

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2013

MEHLHORN MAXI

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2013

ECHAHAMIAN CLAUDE

Consejero delegado
Nombramiento: 25/01/2013

RIUS GARRETA JORGE

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2013

RUBIO RODRIGUEZ VIGIL MARIA EUGENIA

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2013

MONTOYA TOLON ANA

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2013

CARREÑO ALVAREZ IRENE

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2013

GARCIA PETISCO ROCIO

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2013

RASILLA VALTIERRA TERESA

Apoderado
Cese: 25/01/2013

CHOROSZ GILBERT CLAUDE

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 25/01/2013

ECHAHAMIAN CLAUDE

Apoderado
Cese: 12/07/2012

MEDOWS ELIZABETH

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/06/2012

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 23/03/2012

KOENIG SONDRA

Apoderado mancomunado
Cese: 23/03/2012

SMITH JR LEROY

Apoderado mancomunado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por CORNING CABLE SYSTEMS SL

19/01/2015 Detalles del anuncio (19442) Datos registrales: T 20850 , F 195, S 8, H M 19502, I/A 140 ( 9.01.15).

  • Cambio de denominación social

    CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS SL.

16/01/2015 Detalles del anuncio (16807) Datos registrales: T 20850 , F 195, S 8, H M 19502, I/A 139 ( 9.01.15).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

24/12/2013 Detalles del anuncio (548794) Datos registrales: T 20850 , F 194, S 8, H M 19502, I/A 138 (17.12.13).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: KEENAN CHAD A.

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: SINGLOVICS ZSOFIA;TRBOVIC GILLIAN;CSUHAJ KATALIN.

13/06/2013 Detalles del anuncio (272074) Datos registrales: T 20850 , F 193, S 8, H M 19502, I/A 137 ( 5.06.13).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

25/01/2013 Detalles del anuncio (39375) Datos registrales: T 20850 , F 191, S 8, H M 19502, I/A 133 (11.01.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: CHOROSZ GILBERT CLAUDE. Presidente: CHOROSZ GILBERT CLAUDE. Con.Delegado: CHOROSZ GILBERT CLAUDE.

  • Nombramientos

    Consejero: ECHAHAMIAN CLAUDE. Presidente: ECHAHAMIAN CLAUDE.

25/01/2013 Detalles del anuncio (39377) Datos registrales: T 20850 , F 192, S 8, H M 19502, I/A 135 (11.01.13).

  • Revocaciones

    Apoderado: RIUS GARRETA JORGE;RUBIO RODRIGUEZ VIGIL MARIA EUGENIA;MUÑIZ PRIETO MARIA ANGELES;CHOROSZ GILBERT CLAUDE;PINDADO RODRIGUEZ OSCAR;CARLOS GRANJA JOSE;BARTOLOME ASENSIO ELENA;HAMER CHRIS;KULAC TUGCE.

  • Nombramientos

    Apoderado: PINDADO RODRIGUEZ OSCAR;BARTOLOME ASENSIO ELENA;HAMER CHRIS;MEHLHORN MAXI. Con.Delegado: ECHAHAMIAN CLAUDE.

25/01/2013 Detalles del anuncio (39376) Datos registrales: T 20850 , F 191, S 8, H M 19502, I/A 134 (11.01.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: RIUS GARRETA JORGE;RUBIO RODRIGUEZ VIGIL MARIA EUGENIA;MONTOYA TOLON ANA;CARREÑO ALVAREZ IRENE;GARCIA PETISCO ROCIO;RASILLA VALTIERRA TERESA.

25/01/2013 Detalles del anuncio (39378) Datos registrales: T 20850 , F 193, S 8, H M 19502, I/A 136 (11.01.13).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: CHOROSZ GILBERT CLAUDE.

  • Nombramientos

    Apoderado: ECHAHAMIAN CLAUDE.

12/07/2012 Detalles del anuncio (295016) Datos registrales: T 20850 , F 191, S 8, H M 19502, I/A 132 ( 2.07.12).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: MEDOWS ELIZABETH.

14/06/2012 Detalles del anuncio (251597) Datos registrales: T 20850 , F 191, S 8, H M 19502, I/A 131 ( 4.06.12).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 25

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2015-11-28 19/01/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-10-28 16/01/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2013-245-28 24/12/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-110-28 13/06/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-17-28 25/01/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-17-28 25/01/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-17-28 25/01/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-17-28 25/01/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-132-28 12/07/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-112-28 14/06/2012 Madrid Descargar