BOOT SYSTEMS SL

Activa

CL MARQUES DE SENTMENAT NUM.54-58 P.3 PTA.4 (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 06/02/2025

DIAZ PALACIOS RUTH

Apoderado solidario
Nombramiento: 06/02/2025

SANCHEZ SAEZ DE BURUAGA MONICA

Apoderado solidario
Nombramiento: 06/02/2025

JIMENEZ SANCHEZ JORGE

Consejero delegado solidario
Cese: 11/12/2024

LACORTE MARTINEZ CESAR

Administrador único
Nombramiento: 11/12/2024

JIMENEZ SANCHEZ JORGE

Consejero
Nombramiento: 11/12/2024

JIMENEZ SANCHEZ JORGE

Presidente
Nombramiento: 11/12/2024

LACORTE MARTINEZ CESAR

Consejero
Nombramiento: 11/12/2024

CARDONA CANO DOMINGO JOSE

Consejero
Nombramiento: 11/12/2024

LANDERA LURI XABIER

Secretario no consejero
Nombramiento: 31/01/2018

PROAUDIT SLP

Auditor de cuentas
Cese: 25/05/2016

PROAUDIT SLP

Auditor de cuentas
Nombramiento: 14/03/2014

PROAUDIT SLP

Auditor de cuentas
Nombramiento: 28/10/2009

LACORTE MARTINEZ CESAR

Administrador único

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por BOOT SYSTEMS SL

06/02/2025 Detalles del anuncio (58321) Datos registrales: S 8 , H B 393625, I/A 15 (29.01.25).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: DIAZ PALACIOS RUTH.

06/02/2025 Detalles del anuncio (58320) Datos registrales: S 8 , H B 393625, I/A 14 (29.01.25).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: SANCHEZ SAEZ DE BURUAGA MONICA.

06/02/2025 Detalles del anuncio (58318) Datos registrales: S 8 , H B 393625, I/A 13 (29.01.25).

  • Nombramientos

    CONS.DEL.SOL: JIMENEZ SANCHEZ JORGE.

11/12/2024 Detalles del anuncio (534486) Datos registrales: S 8 , H B 393625, I/A 12 ( 3.12.24).

  • Otros Conceptos

    DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: IBERIAN UNIT VAR GROUP S.L.

11/12/2024 Detalles del anuncio (534484) Datos registrales: S 8 , H B 393625, I/A 11 ( 3.12.24).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: LACORTE MARTINEZ CESAR.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: JIMENEZ SANCHEZ JORGE. PRESIDENTE: JIMENEZ SANCHEZ JORGE. CONSEJERO: LACORTE MARTINEZ CESAR;CARDONA CANO DOMINGO JOSE. SECR.NO CONS: LANDERA LURI XABIER.

19/07/2023 Detalles del anuncio (325847) Datos registrales: T 41461 , F 89, S 8, H B 393625, I/A 10 (11.07.23).

  • Cambio de domicilio social

    CL MARQUES DE SENTMENAT NUM.54-58 P.3 PTA.4 (BARCELONA).

27/07/2022 Detalles del anuncio (345641) Datos registrales: T 41461 , F 88, S 8, H B 393625, I/A 9 (19.07.22).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 7.520,00 Euros. Resultante Suscrito: 20.230,00 Euros.

14/03/2018 Detalles del anuncio (118657) Datos registrales: T 41461 , F 88, S 8, H B 393625, I/A 8 ( 7.03.18).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 2.310,00 Euros. Resultante Suscrito: 27.750,00 Euros.

05/02/2018 Detalles del anuncio (56154) Datos registrales: T 41461 , F 88, S 8, H B 393625, I/A 7 (29.01.18).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 27.054,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.060,00 Euros.

31/01/2018 Detalles del anuncio (48836) Datos registrales: T 41461 , F 87, S 8, H B 393625, I/A 6 (23.01.18).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: PROAUDIT SLP.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 17

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2025-25-08 06/02/2025 Barcelona Descargar
BORME-A-2025-25-08 06/02/2025 Barcelona Descargar
BORME-A-2025-25-08 06/02/2025 Barcelona Descargar
BORME-A-2024-238-08 11/12/2024 Barcelona Descargar
BORME-A-2024-238-08 11/12/2024 Barcelona Descargar
BORME-A-2023-136-08 19/07/2023 Barcelona Descargar
BORME-A-2022-142-08 27/07/2022 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-52-08 14/03/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-25-08 05/02/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-22-08 31/01/2018 Barcelona Descargar