ARICEM RECURSOS MINEROS SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 18/10/2013 | MONJE GUTIERREZ SUSANA |
Apoderado |
| Nombramiento: 22/08/2012 | LOPEZ YUSTE JUAN |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 22/08/2012 | BIGORRA PAEZ JOSEP MARIA |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 22/08/2012 | ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 22/08/2012 | ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO |
Apoderado solidario |
| Cese: 22/08/2012 | ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 30/12/2010 | ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 30/12/2010 | ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 30/12/2010 | ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 30/12/2010 | ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 24/02/2010 | BIGORRA PAEZ JOSEP MARIA |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 24/02/2010 | ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER |
Apoderado mancomunado solidario |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ARICEM RECURSOS MINEROS SL
18/10/2013 Detalles del anuncio (447159) Datos registrales: T 21189 , F 224, S 8, H M 376288, I/A 16 ( 8.10.13).
- Nombramientos
Apoderado: MONJE GUTIERREZ SUSANA.
22/08/2012 Detalles del anuncio (350777) Datos registrales: T 21189 , F 222, S 8, H M 376288, I/A 14 ( 9.08.12).
- Nombramientos
Apo.Man.Soli: LOPEZ YUSTE JUAN;BIGORRA PAEZ JOSEP MARIA;ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER.
22/08/2012 Detalles del anuncio (350778) Datos registrales: T 21189 , F 224, S 8, H M 376288, I/A 15 ( 9.08.12).
- Revocaciones
Apo.Sol.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Apo.Manc.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO.
04/10/2011 Detalles del anuncio (685850)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2011) Año: 2010
30/12/2010 Detalles del anuncio (486197) Datos registrales: T 21189 , F 220, S 8, H M 376288, I/A 13 (20.12.10).
- Nombramientos
Apo.Sol.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Apo.Manc.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Apo.Sol.: ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER.
14/10/2010 Detalles del anuncio (824147)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2010) Año: 2009
24/02/2010 Detalles del anuncio (79362) Datos registrales: T 21189 , F 166, S 8, H M 376288, I/A 12 (15.02.10).
- Nombramientos
Apo.Man.Soli: BIGORRA PAEZ JOSEP MARIA;ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER.
16/12/2009 Detalles del anuncio (524197) Datos registrales: T 21189 , F 165, S 8, H M 376288, I/A 11 ( 4.12.09).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 3.884.296,64 Euros. Resultante Suscrito: 3.621.234,68 Euros.
27/11/2009 Detalles del anuncio (953208)
- Depósitos de cuentas anuales
(Noviembre de 2009) Año: 2007
26/11/2009 Detalles del anuncio (948448)
- Depósitos de cuentas anuales
(Noviembre de 2009) Año: 2008
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2013-200-28 | 18/10/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-160-28 | 22/08/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-160-28 | 22/08/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2011-189-28 | 04/10/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2010-249-28 | 30/12/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2010-198-28 | 14/10/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2010-37-28 | 24/02/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2009-239-28 | 16/12/2009 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2009-227-28 | 27/11/2009 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2009-226-28 | 26/11/2009 | Madrid | Descargar |