ALERTA Y CONTROL SA

Activa

C/ HAYA 7- A 4º PLANTA (MADRID).
Madrid  (28019)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 20/02/2025

STELLATO ANGELO

Administrador único
Nombramiento: 22/09/2023

LUIS CARUANA & ASOCIADOS SL

Auditor
Nombramiento: 06/07/2021

ROMERO VALDIVIESO BEATRIZ

Apoderado
Cese: 17/12/2020

OLIVI ROBERTO

Consejero
Cese: 17/12/2020

STELLATO ANGELO

Consejero
Cese: 17/12/2020

STELLATO ANGELO

Presidente
Cese: 17/12/2020

DEGRASSI MICHELE

Consejero
Cese: 17/12/2020

LENTINI DANIELE

Secretario no consejero
Nombramiento: 17/12/2020

STELLATO ANGELO

Administrador único
Cese: 09/03/2020

DEL CASTILLO SERRANO ANA BELEN

Consejero
Nombramiento: 09/03/2020

DEGRASSI MICHELE

Consejero
Nombramiento: 23/01/2019

STELLATO ANGELO

Apoderado solidario
Cese: 23/01/2019

PASSALACQUA CLAUDIO

Consejero
Cese: 23/01/2019

PASSALACQUA CLAUDIO

Presidente
Nombramiento: 23/01/2019

STELLATO ANGELO

Consejero
Nombramiento: 23/01/2019

STELLATO ANGELO

Presidente
Cese: 24/07/2018

DEL CASTILLO PEINADO PEDRO JOSE

Presidente
Cese: 24/07/2018

SERRANO CABAÑAS MARIA EUGENIA

Secretario
Cese: 24/07/2018

DEL CASTILLO PEINADO PEDRO JOSE

Consejero
Cese: 24/07/2018

DEL CASTILLO SERRANO JUAN PEDRO

Consejero
Cese: 24/07/2018

SERRANO CABAÑAS MARIA EUGENIA

Consejero
Cese: 24/07/2018

DEL CASTILLO SERRANO ANA BELEN

Consejero
Cese: 24/07/2018

DEL CASTILLO SERRANO CARLOS ALBERTO

Consejero
Nombramiento: 24/07/2018

LENTINI DANIELE

Secretario no consejero
Nombramiento: 24/07/2018

PASSALACQUA CLAUDIO

Consejero
Nombramiento: 24/07/2018

OLIVI ROBERTO

Consejero
Nombramiento: 24/07/2018

DEL CASTILLO SERRANO ANA BELEN

Consejero
Nombramiento: 24/07/2018

PASSALACQUA CLAUDIO

Presidente
Nombramiento: 24/07/2018

PASSALACQUA CLAUDIO

Apoderado solidario
Nombramiento: 15/11/2017

DEL CASTILLO PEINADO PEDRO JOSE

Presidente
Nombramiento: 15/11/2017

SERRANO CABAÑAS MARIA EUGENIA

Secretario
Nombramiento: 15/11/2017

DEL CASTILLO PEINADO PEDRO JOSE

Consejero
Nombramiento: 15/11/2017

DEL CASTILLO SERRANO JUAN PEDRO

Consejero
Nombramiento: 15/11/2017

SERRANO CABAÑAS MARIA EUGENIA

Consejero
Nombramiento: 15/11/2017

DEL CASTILLO SERRANO ANA BELEN

Consejero
Nombramiento: 15/11/2017

DEL CASTILLO SERRANO CARLOS ALBERTO

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ALERTA Y CONTROL SA

20/02/2025 Detalles del anuncio (85461) Datos registrales: S 8 , H M 60559, I/A 67 (13.02.25).

  • Reelecciones

    Adm. Unico: STELLATO ANGELO.

22/09/2023 Detalles del anuncio (410921) Datos registrales: T 41219 , F 62, S 8, H M 60559, I/A 66 (15.09.23).

  • Reelecciones

    Auditor: LUIS CARUANA & ASOCIADOS SL.

09/12/2022 Detalles del anuncio (538433) Datos registrales: T 41219 , F 61, S 8, H M 60559, I/A 65 (30.11.22).

  • Cambio de domicilio social

    C/ HAYA 7- A 4º PLANTA (MADRID).

06/07/2021 Detalles del anuncio (325114) Datos registrales: T 41219 , F 61, S 8, H M 60559, I/A 64 (29.06.21).

  • Nombramientos

    Apoderado: ROMERO VALDIVIESO BEATRIZ.

17/12/2020 Detalles del anuncio (446551) Datos registrales: T 25134 , F 198, S 8, H M 60559, I/A 62 (10.12.20).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: OLIVI ROBERTO;STELLATO ANGELO. Presidente: STELLATO ANGELO. Consejero: DEGRASSI MICHELE. SecreNoConsj: LENTINI DANIELE.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: STELLATO ANGELO.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

08/05/2020 Detalles del anuncio (154300) Datos registrales: T 25134 , F 197, S 8, H M 60559, I/A 61 (30.04.20).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 601.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 200.000,00 Euros. Desembolsado: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 200.000,00 Euros.

09/03/2020 Detalles del anuncio (107520) Datos registrales: T 25134 , F 197, S 8, H M 60559, I/A 60 ( 2.03.20).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DEL CASTILLO SERRANO ANA BELEN.

  • Nombramientos

    Consejero: DEGRASSI MICHELE.

07/08/2019 Detalles del anuncio (346417) Datos registrales: T 25134 , F 197, S 8, H M 60559, I/A 59 (31.07.19).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    PJC SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO REUNIDOS.

07/05/2019 Detalles del anuncio (193408) Datos registrales: T 25134 , F 196, S 8, H M 60559, I/A 58 (26.04.19).

  • Modificaciones Estatutarias

    SE MODIFICA EL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE REGULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

23/01/2019 Detalles del anuncio (30045) Datos registrales: T 25134 , F 194, S 8, H M 60559, I/A 55 (16.01.19).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: STELLATO ANGELO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 25

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2025-35-28 20/02/2025 Madrid Descargar
BORME-A-2023-182-28 22/09/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2022-233-28 09/12/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-127-28 06/07/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-241-28 17/12/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2020-88-28 08/05/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2020-47-28 09/03/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-150-28 07/08/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-85-28 07/05/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-15-28 23/01/2019 Madrid Descargar