AGUILEÑA DE CULTIVOS SL

Activa

C/ INMACULADA 10 BAJO (AGUILAS).
 Águilas, Murcia
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 19/04/2024

BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES SAP

Auditor
Cese: 11/07/2018

PABLO GALLU RIOS

Administrador mancomunado
Cese: 11/07/2018

JOSE DAVID SANCHEZ ASENSIO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 11/07/2018

MARTIN HERNANDEZ GIMENEZ

Administrador mancomunado
Nombramiento: 11/07/2018

JOSE GINES GARCIA PIÑERO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 11/07/2018

JOSE-MIGUEL GARCIA HERNANDEZ

Administrador mancomunado
Cese: 18/01/2013

ANGEL MARTINEZ MENDEZ

Administrador mancomunado
Cese: 18/01/2013

JOSE GINES GARCIA PIÑERO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 18/01/2013

PABLO GALLU RIOS

Administrador mancomunado
Nombramiento: 11/12/2012

ABANTE AUDIEST AUDITORES SAP

Auditor
Cese: 20/12/2011

ISABEL GARCIA MORENO

Consejero
Cese: 20/12/2011

JOSE GINES GARCIA PIÑERO

Consejero
Cese: 20/12/2011

MARIA SOLEDAD MARTINEZ LOPEZ

Consejero
Cese: 20/12/2011

JOSE DAVID SANCHEZ ASENSIO

Consejero
Cese: 20/12/2011

ANGEL MARTINEZ MENDEZ

Consejero
Cese: 20/12/2011

JOSE GINES GARCIA PIÑERO

Secretario
Cese: 20/12/2011

JOSE DAVID SANCHEZ ASENSIO

Consejero delegado mancomunado
Cese: 20/12/2011

JOSE GINES GARCIA PIÑERO

Consejero delegado mancomunado
Cese: 20/12/2011

MARIA SOLEDAD MARTINEZ LOPEZ

Consejero delegado mancomunado
Cese: 20/12/2011

ANGEL MARTINEZ MENDEZ

Consejero delegado mancomunado
Cese: 20/12/2011

ISABEL GARCIA MORENO

Consejero delegado mancomunado
Cese: 20/12/2011

ISABEL GARCIA MORENO

Vicepresidente
Cese: 20/12/2011

JOSE MIGUEL GARCIA MORENO

Consejero
Cese: 20/12/2011

JOSE MIGUEL GARCIA MORENO

Presidente
Cese: 20/12/2011

JOSE MIGUEL GARCIA MORENO

Consejero delegado
Nombramiento: 20/12/2011

JOSE GINES GARCIA PIÑERO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 20/12/2011

MARIA SOLEDAD MARTINEZ LOPEZ

Administrador mancomunado
Nombramiento: 20/12/2011

JOSE DAVID SANCHEZ ASENSIO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 20/12/2011

ANGEL MARTINEZ MENDEZ

Administrador mancomunado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por AGUILEÑA DE CULTIVOS SL

19/04/2024 Detalles del anuncio (188736) Datos registrales: T 1378 , F 129, S 8, H MU 24306, I/A 13 (12.04.24).

  • Nombramientos

    Auditor: BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES S.A.P.

11/07/2018 Detalles del anuncio (288805) Datos registrales: T 1378 , F 128, S 8, H MU 24306, I/A 12 ( 4.07.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: PABLO GALLU RIOS;JOSE DAVID SANCHEZ ASENSIO.

  • Nombramientos

    Adm. Mancom.: MARTIN HERNANDEZ GIMENEZ;JOSE GINES GARCIA PIÑERO;JOSE-MIGUEL GARCIA HERNANDEZ.

  • Otros Conceptos

    Se modifica el artículo 8.1 y 9.1 apartado c) de los estatutos sociales.-

  • Cambio de domicilio social

    C/ INMACULADA 10 BAJO (AGUILAS).

17/02/2016 Detalles del anuncio (71924) Datos registrales: T 1378 , F 128, S 8, H MU 24306, I/A 11 (10.02.16).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 26.421,00 Euros. Resultante Suscrito: 308.949,56 Euros.

21/03/2014 Detalles del anuncio (129409) Datos registrales: T 1378 , F 127, S 8, H MU 24306, I/A 10 (14.03.14).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 13.386,64 Euros. Resultante Suscrito: 335.370,56 Euros.

18/01/2013 Detalles del anuncio (26868) Datos registrales: T 1378 , F 127, S 8, H MU 24306, I/A 9 (14.01.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: ANGEL MARTINEZ MENDEZ;JOSE GINES GARCIA PIÑERO.

  • Nombramientos

    Adm. Mancom.: PABLO GALLU RIOS.

20/12/2012 Detalles del anuncio (529617) Datos registrales: T 1378 , F 126, S 8, H MU 24306, I/A 8 (13.12.12).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 2.818,24 Euros. Resultante Suscrito: 348.757,20 Euros.

11/12/2012 Detalles del anuncio (513067) Datos registrales: T 1378 , F 126, S 8, H MU 24306, I/A 7 ( 4.12.12).

  • Nombramientos

    Auditor: ABANTE AUDIEST AUDITORES SAP.

20/12/2011 Detalles del anuncio (504617) Datos registrales: T 1378 , F 126, S 8, H MU 24306, I/A 6 ( 7.12.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ISABEL GARCIA MORENO;JOSE GINES GARCIA PIÑERO;MARIA SOLEDAD MARTINEZ LOPEZ;JOSE DAVID SANCHEZ ASENSIO;ANGEL MARTINEZ MENDEZ. Secretario: JOSE GINES GARCIA PIÑERO. Cons.Del.Man: JOSE DAVID SANCHEZ ASENSIO;JOSE GINES GARCIA PIÑERO;MARIA SOLEDAD MARTINEZ LOPEZ;ANGEL MARTINEZ MENDEZ;ISABEL GARCIA MORENO. Vicepresid.: ISABEL GARCIA MORENO. Consejero: JOSE MIGUEL GARCIA MORENO. Presidente: JOSE MIGUEL GARCIA MORENO. Con.Delegado: JOSE MIGUEL GARCIA MORENO.

  • Nombramientos

    Adm. Mancom.: JOSE GINES GARCIA PIÑERO;MARIA SOLEDAD MARTINEZ LOPEZ;JOSE DAVID SANCHEZ ASENSIO;ANGEL MARTINEZ MENDEZ.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados.

  • Cambio de domicilio social

    C/ VAZQUEZ MONTALBAN 10 B (AGUILAS).

12/01/2011 Detalles del anuncio (17113)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Diciembre de 2010) Año: 2009

27/07/2010 Detalles del anuncio (294687) Datos registrales: T 1378 , F 126, S 8, H MU 24306, I/A 5 (19.07.10).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 4.227,36 Euros. Resultante Suscrito: 351.575,44 Euros.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2024-77-30 19/04/2024 Murcia Descargar
BORME-A-2018-132-30 11/07/2018 Murcia Descargar
BORME-A-2016-32-30 17/02/2016 Murcia Descargar
BORME-A-2014-56-30 21/03/2014 Murcia Descargar
BORME-A-2013-12-30 18/01/2013 Murcia Descargar
BORME-A-2012-243-30 20/12/2012 Murcia Descargar
BORME-A-2012-236-30 11/12/2012 Murcia Descargar
BORME-A-2011-239-30 20/12/2011 Murcia Descargar
BORME-B-2011-7-30 12/01/2011 Murcia Descargar
BORME-A-2010-142-30 27/07/2010 Murcia Descargar