AGASEMAP SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 21/03/2022 | DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO |
Apoderado solidario |
| Cese: 28/04/2016 | DE MIGUEL RUIZ MARGARITA |
Consejero |
| Cese: 28/04/2016 | DE MIGUEL RUIZ MARGARITA |
Secretario |
| Nombramiento: 28/04/2016 | DE MIGUEL CAMPANARIO SARAY |
Consejero |
| Nombramiento: 28/04/2016 | DE MIGUEL CAMPANARIO SARAY |
Secretario |
| Cese: 14/04/2016 | DE MIGUEL RUIZ MARGARITA |
Apoderado |
| Cese: 31/03/2011 | CAMPANARIO VERA JULIA |
Administrador |
| Nombramiento: 31/03/2011 | CAMPANARIO VERA JULIA |
Consejero |
| Nombramiento: 31/03/2011 | CAMPANARIO VERA JULIA |
Presidente |
| Nombramiento: 31/03/2011 | CAMPANARIO VERA JULIA |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 31/03/2011 | DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO |
Consejero |
| Nombramiento: 31/03/2011 | DE MIGUEL RUIZ MARGARITA |
Consejero |
| Nombramiento: 31/03/2011 | DE MIGUEL RUIZ MARGARITA |
Secretario |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por AGASEMAP SL
21/03/2022 Detalles del anuncio (122799) Datos registrales: T 24921 , F 33, S 8, H B 81084, I/A 9 ( 9.03.22).
- Nombramientos
APODERAD.SOL: DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO.
30/04/2021 Detalles del anuncio (198026) Datos registrales: T 24921 , F 30, S 8, H B 81084, I/A 8 (23.04.21).
- Ampliación de Capital
Capital: 13.642,70 Euros. Resultante Suscrito: 38.764,50 Euros.
- Cambio de objeto social
LA ACTIVIDAD DE AGENCIA DE SEGUROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO LEY 3/2020 DE 4 DE FEBRERO,LA COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.ETC.
- Fusión por Absorción
Sociedades absorbidas: RISMAP 10 SL. M S C SIGLO XXI SL.
28/04/2016 Detalles del anuncio (184448) Datos registrales: T 24921 , F 30, S 8, H B 81084, I/A 7 (20.04.16).
- Revocaciones
CONSEJERO: DE MIGUEL RUIZ MARGARITA. SECRETARIO: DE MIGUEL RUIZ MARGARITA.
- Nombramientos
CONSEJERO: DE MIGUEL CAMPANARIO SARAY. SECRETARIO: DE MIGUEL CAMPANARIO SARAY.
14/04/2016 Detalles del anuncio (162996) Datos registrales: T 24921 , F 30, S 8, H B 81084, I/A 6 ( 6.04.16).
- Revocaciones
APODERADO: DE MIGUEL RUIZ MARGARITA.
16/12/2011 Detalles del anuncio (984102)
- Depósitos de cuentas anuales
(Noviembre de 2011) Año: 2010
31/03/2011 Detalles del anuncio (144414) Datos registrales: T 24921 , F 29, S 8, H B 81084, I/A 5 (21.03.11).
- Revocaciones
ADMINISTR.: CAMPANARIO VERA JULIA.
- Nombramientos
CONSEJERO: CAMPANARIO VERA JULIA. PRESIDENTE: CAMPANARIO VERA JULIA. CONS. DELEG.: CAMPANARIO VERA JULIA. CONSEJERO: DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO;DE MIGUEL RUIZ MARGARITA. SECRETARIO: DE MIGUEL RUIZ MARGARITA.
- Reducción de Capital
Importe reducción: 0,06 Euros. Resultante Suscrito: 3.005,00 Euros.
- Ampliación de Capital
Capital: 22.116,80 Euros. Resultante Suscrito: 25.121,80 Euros.
25/08/2010 Detalles del anuncio (361911)
- Depósitos de cuentas anuales
(Julio de 2010) Año: 2009
22/12/2009 Detalles del anuncio (1038987)
- Depósitos de cuentas anuales
(Noviembre de 2009) Año: 2008
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 8
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2022-55-08 | 21/03/2022 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2021-81-08 | 30/04/2021 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2016-81-08 | 28/04/2016 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2016-71-08 | 14/04/2016 | Barcelona | Descargar |
| BORME-B-2011-237-08 | 16/12/2011 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2011-63-08 | 31/03/2011 | Barcelona | Descargar |
| BORME-B-2010-163-08 | 25/08/2010 | Barcelona | Descargar |
| BORME-B-2009-243-08 | 22/12/2009 | Barcelona | Descargar |