1NKEMIA IUCT GROUP SA
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 30/07/2024 | CAPA AUDITORES SL |
Auditor |
| Nombramiento: 07/09/2016 | RSM SPAIN AUDITORES SLP |
Auditor de cuentas |
| Nombramiento: 06/05/2016 | COS GARCIA DAVID |
Apoderado solidario mancomunado |
| Nombramiento: 06/05/2016 | CASTELLS BOLIART JOSEP |
Apoderado solidario mancomunado |
| Cese: 17/03/2016 | COS GARCIA DAVID |
Consejero |
| Cese: 17/03/2016 | COS GARCIA DAVID |
Vicepresidente |
| Cese: 17/03/2016 | COS GARCIA DAVID |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 17/03/2016 | CASTELLS BOLIART JOSEP |
Consejero |
| Nombramiento: 17/03/2016 | CASTELLS BOLIART JOSEP |
Presidente |
| Nombramiento: 17/03/2016 | ARCO TORRES ANTONIO MANUEL |
Consejero |
| Nombramiento: 17/03/2016 | ARCO TORRES ANTONIO MANUEL |
Secretario |
| Nombramiento: 17/03/2016 | ESTEVEZ COMPANY CARLOS |
Consejero |
| Nombramiento: 17/03/2016 | BERTOLIN EDO JOSE RAMON |
Consejero |
| Nombramiento: 17/03/2016 | BERTOLIN EDO JOSE RAMON |
Vicesecretario |
| Nombramiento: 17/03/2016 | JUNYENT ARGIMON GUILLEM |
Consejero |
| Nombramiento: 17/03/2016 | ESCOLA SANT GERVASI SCCL |
Consejero |
| Nombramiento: 17/03/2016 | COS GARCIA DAVID |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 17/03/2016 | GIL RODRIGUEZ HECTOR |
Consejero |
| Nombramiento: 17/03/2016 | PONT MERINO ESTHER |
Consejero |
| Nombramiento: 17/03/2016 | ESCOLA SANT GERVASI SCCL |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 17/03/2016 | ESCOLA SANT GERVASI SCCL |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 17/03/2016 | CASTELLS BOLIART JOSEP |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 26/11/2013 | SELVA BUTJOSA DANIEL |
Consejero |
| Cese: 26/11/2013 | SELVA BUTJOSA DANIEL |
Vicesecretario |
| Nombramiento: 26/11/2013 | BERTOLIN EDO JOSE RAMON |
Consejero |
| Nombramiento: 26/11/2013 | BERTOLIN EDO JOSE RAMON |
Vicesecretario |
| Nombramiento: 15/10/2013 | RSM GASSO AUDITORES SLP |
Auditor de cuentas |
| Nombramiento: 15/10/2013 | JUNYENT ARGIMON GUILLEM |
Consejero |
| Cese: 24/12/2012 | CALZADA PUJOL ANGELES |
Consejero |
| Nombramiento: 24/12/2012 | JUNYENT ARGIMON GUILLEM |
Consejero |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por 1NKEMIA IUCT GROUP SA
30/07/2024 Detalles del anuncio (335813) Datos registrales: S 8 , H M 665835, I/A 4 (22.07.24).
- Nombramientos
Auditor: CAPA AUDITORES SL.
14/03/2019 Detalles del anuncio (117909) Datos registrales: T 37340 , F 219, S 8, H M 665835, I/A 3 ( 7.03.19).
- Nombramientos
Com.Sin.bon: MARKETS COUNSELORS SL.
- Otros Conceptos
EMISION DE UN TOTAL DE 50 BONOS, VALOR UNITARIO DE LOS BONOS EMITIDOS ES DE 100.000 EUROS, CON VENCIMIENTO FINAL EL 30 DE ENERO DE 2023, POR IMPORTE DE 5.000.000 EUROS.
06/04/2018 Detalles del anuncio (154156) Datos registrales: T 37340 , F 219, S 8, H M 665835, I/A 2 (28.03.18).
- Cambio de domicilio social
C/ SANTIAGO GRISOLIA 2 (TRES CANTOS).
26/05/2017 Detalles del anuncio (219082) Datos registrales: T 43092 , F 190, S 8, H B 402573, I/A 15 (17.05.17).
- Ampliación de Capital
Suscrito: 106.031,80 Euros. Desembolsado: 106.031,80 Euros. Resultante Suscrito: 2.698.182,10 Euros. Resultante Desembolsado: 2.698.182,10 Euros.
07/09/2016 Detalles del anuncio (367304) Datos registrales: T 43092 , F 190, S 8, H B 402573, I/A 14 (31.08.16).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: RSM SPAIN AUDITORES SLP.
- Modificaciones Estatutarias
MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,RELATIVO A LA TRANSMISION DE ACCIONES.
06/05/2016 Detalles del anuncio (195351) Datos registrales: T 43092 , F 189, S 8, H B 402573, I/A 13 (28.04.16).
- Nombramientos
APOD.SOL/MAN: COS GARCIA DAVID;CASTELLS BOLIART JOSEP.
17/03/2016 Detalles del anuncio (123094) Datos registrales: T 43092 , F 187, S 8, H B 402573, I/A 12 ( 8.03.16).
- Revocaciones
CONSEJERO: COS GARCIA DAVID. VICEPRESIDEN: COS GARCIA DAVID. CONS. DELEG.: COS GARCIA DAVID.
- Nombramientos
CONSEJERO: CASTELLS BOLIART JOSEP. PRESIDENTE: CASTELLS BOLIART JOSEP. CONSEJERO: ARCO TORRES ANTONIO MANUEL. SECRETARIO: ARCO TORRES ANTONIO MANUEL. CONSEJERO: ESTEVEZ COMPANY CARLOS;BERTOLIN EDO JOSE RAMON. VICESECRET.: BERTOLIN EDO JOSE RAMON. CONSEJERO: JUNYENT ARGIMON GUILLEM;ESCOLA SANT GERVASI SCCL. REPR.143 RRM: COS GARCIA DAVID. CONSEJERO: GIL RODRIGUEZ HECTOR;PONT MERINO ESTHER. VICEPRESIDEN: ESCOLA SANT GERVASI SCCL. CONS.DEL.MAN: ESCOLA SANT GERVASI SCCL;CASTELLS BOLIART JOSEP.
- Modificaciones Estatutarias
MODIFICACION DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICION DEL ARTICULO 15 BIS A LOS MISMOS. RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES Y RETRIBUCION A DIRECTIVOS Y/O TERCEROS.
04/09/2014 Detalles del anuncio (355414) Datos registrales: T 43092 , F 185, S 8, H B 402573, I/A 11 (29.08.14).
- Ampliación de Capital
Suscrito: 235.650,00 Euros. Desembolsado: 235.650,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.592.150,30 Euros. Resultante Desembolsado: 2.592.150,30 Euros.
- Otros Conceptos
DEJACION SIN EFECTO DE LA AUTORIZACION AL ORGANO DE ADMINISTRACION PARA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL Y NUEVA AUTORIZACION AL ORGANO DE ADMINISTRACION PARA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL.
26/11/2013 Detalles del anuncio (503047) Datos registrales: T 43092 , F 185, S 8, H B 402573, I/A 10 (15.11.13).
- Revocaciones
CONSEJERO: SELVA BUTJOSA DANIEL. VICESECRET.: SELVA BUTJOSA DANIEL.
- Nombramientos
CONSEJERO: BERTOLIN EDO JOSE RAMON. VICESECRET.: BERTOLIN EDO JOSE RAMON.
15/10/2013 Detalles del anuncio (440105) Datos registrales: T 43092 , F 185, S 8, H B 402573, I/A 9 ( 4.10.13).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: RSM GASSO AUDITORES SLP. CONSEJERO: JUNYENT ARGIMON GUILLEM.
- Modificaciones Estatutarias
ART.6,PARRAFO 5:TRANSMISION DE ACCIONES.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2024-145-28 | 30/07/2024 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2019-51-28 | 14/03/2019 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2018-67-28 | 06/04/2018 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-98-08 | 26/05/2017 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2016-171-08 | 07/09/2016 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2016-86-08 | 06/05/2016 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2016-53-08 | 17/03/2016 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-168-08 | 04/09/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-226-08 | 26/11/2013 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-197-08 | 15/10/2013 | Barcelona | Descargar |