1NKEMIA IUCT GROUP SA

Activa

C/ SANTIAGO GRISOLIA 2 (TRES CANTOS).
 Tres Cantos, Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 30/07/2024

CAPA AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 07/09/2016

RSM SPAIN AUDITORES SLP

Auditor de cuentas
Nombramiento: 06/05/2016

COS GARCIA DAVID

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 06/05/2016

CASTELLS BOLIART JOSEP

Apoderado solidario mancomunado
Cese: 17/03/2016

COS GARCIA DAVID

Consejero
Cese: 17/03/2016

COS GARCIA DAVID

Vicepresidente
Cese: 17/03/2016

COS GARCIA DAVID

Consejero delegado
Nombramiento: 17/03/2016

CASTELLS BOLIART JOSEP

Consejero
Nombramiento: 17/03/2016

CASTELLS BOLIART JOSEP

Presidente
Nombramiento: 17/03/2016

ARCO TORRES ANTONIO MANUEL

Consejero
Nombramiento: 17/03/2016

ARCO TORRES ANTONIO MANUEL

Secretario
Nombramiento: 17/03/2016

ESTEVEZ COMPANY CARLOS

Consejero
Nombramiento: 17/03/2016

BERTOLIN EDO JOSE RAMON

Consejero
Nombramiento: 17/03/2016

BERTOLIN EDO JOSE RAMON

Vicesecretario
Nombramiento: 17/03/2016

JUNYENT ARGIMON GUILLEM

Consejero
Nombramiento: 17/03/2016

ESCOLA SANT GERVASI SCCL

Consejero
Nombramiento: 17/03/2016

COS GARCIA DAVID

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 17/03/2016

GIL RODRIGUEZ HECTOR

Consejero
Nombramiento: 17/03/2016

PONT MERINO ESTHER

Consejero
Nombramiento: 17/03/2016

ESCOLA SANT GERVASI SCCL

Vicepresidente
Nombramiento: 17/03/2016

ESCOLA SANT GERVASI SCCL

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 17/03/2016

CASTELLS BOLIART JOSEP

Consejero delegado mancomunado
Cese: 26/11/2013

SELVA BUTJOSA DANIEL

Consejero
Cese: 26/11/2013

SELVA BUTJOSA DANIEL

Vicesecretario
Nombramiento: 26/11/2013

BERTOLIN EDO JOSE RAMON

Consejero
Nombramiento: 26/11/2013

BERTOLIN EDO JOSE RAMON

Vicesecretario
Nombramiento: 15/10/2013

RSM GASSO AUDITORES SLP

Auditor de cuentas
Nombramiento: 15/10/2013

JUNYENT ARGIMON GUILLEM

Consejero
Cese: 24/12/2012

CALZADA PUJOL ANGELES

Consejero
Nombramiento: 24/12/2012

JUNYENT ARGIMON GUILLEM

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por 1NKEMIA IUCT GROUP SA

30/07/2024 Detalles del anuncio (335813) Datos registrales: S 8 , H M 665835, I/A 4 (22.07.24).

  • Nombramientos

    Auditor: CAPA AUDITORES SL.

14/03/2019 Detalles del anuncio (117909) Datos registrales: T 37340 , F 219, S 8, H M 665835, I/A 3 ( 7.03.19).

  • Nombramientos

    Com.Sin.bon: MARKETS COUNSELORS SL.

  • Otros Conceptos

    EMISION DE UN TOTAL DE 50 BONOS, VALOR UNITARIO DE LOS BONOS EMITIDOS ES DE 100.000 EUROS, CON VENCIMIENTO FINAL EL 30 DE ENERO DE 2023, POR IMPORTE DE 5.000.000 EUROS.

06/04/2018 Detalles del anuncio (154156) Datos registrales: T 37340 , F 219, S 8, H M 665835, I/A 2 (28.03.18).

  • Cambio de domicilio social

    C/ SANTIAGO GRISOLIA 2 (TRES CANTOS).

26/05/2017 Detalles del anuncio (219082) Datos registrales: T 43092 , F 190, S 8, H B 402573, I/A 15 (17.05.17).

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 106.031,80 Euros. Desembolsado: 106.031,80 Euros. Resultante Suscrito: 2.698.182,10 Euros. Resultante Desembolsado: 2.698.182,10 Euros.

07/09/2016 Detalles del anuncio (367304) Datos registrales: T 43092 , F 190, S 8, H B 402573, I/A 14 (31.08.16).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: RSM SPAIN AUDITORES SLP.

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,RELATIVO A LA TRANSMISION DE ACCIONES.

06/05/2016 Detalles del anuncio (195351) Datos registrales: T 43092 , F 189, S 8, H B 402573, I/A 13 (28.04.16).

  • Nombramientos

    APOD.SOL/MAN: COS GARCIA DAVID;CASTELLS BOLIART JOSEP.

17/03/2016 Detalles del anuncio (123094) Datos registrales: T 43092 , F 187, S 8, H B 402573, I/A 12 ( 8.03.16).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: COS GARCIA DAVID. VICEPRESIDEN: COS GARCIA DAVID. CONS. DELEG.: COS GARCIA DAVID.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: CASTELLS BOLIART JOSEP. PRESIDENTE: CASTELLS BOLIART JOSEP. CONSEJERO: ARCO TORRES ANTONIO MANUEL. SECRETARIO: ARCO TORRES ANTONIO MANUEL. CONSEJERO: ESTEVEZ COMPANY CARLOS;BERTOLIN EDO JOSE RAMON. VICESECRET.: BERTOLIN EDO JOSE RAMON. CONSEJERO: JUNYENT ARGIMON GUILLEM;ESCOLA SANT GERVASI SCCL. REPR.143 RRM: COS GARCIA DAVID. CONSEJERO: GIL RODRIGUEZ HECTOR;PONT MERINO ESTHER. VICEPRESIDEN: ESCOLA SANT GERVASI SCCL. CONS.DEL.MAN: ESCOLA SANT GERVASI SCCL;CASTELLS BOLIART JOSEP.

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICION DEL ARTICULO 15 BIS A LOS MISMOS. RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES Y RETRIBUCION A DIRECTIVOS Y/O TERCEROS.

04/09/2014 Detalles del anuncio (355414) Datos registrales: T 43092 , F 185, S 8, H B 402573, I/A 11 (29.08.14).

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 235.650,00 Euros. Desembolsado: 235.650,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.592.150,30 Euros. Resultante Desembolsado: 2.592.150,30 Euros.

  • Otros Conceptos

    DEJACION SIN EFECTO DE LA AUTORIZACION AL ORGANO DE ADMINISTRACION PARA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL Y NUEVA AUTORIZACION AL ORGANO DE ADMINISTRACION PARA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL.

26/11/2013 Detalles del anuncio (503047) Datos registrales: T 43092 , F 185, S 8, H B 402573, I/A 10 (15.11.13).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: SELVA BUTJOSA DANIEL. VICESECRET.: SELVA BUTJOSA DANIEL.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: BERTOLIN EDO JOSE RAMON. VICESECRET.: BERTOLIN EDO JOSE RAMON.

15/10/2013 Detalles del anuncio (440105) Datos registrales: T 43092 , F 185, S 8, H B 402573, I/A 9 ( 4.10.13).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: RSM GASSO AUDITORES SLP. CONSEJERO: JUNYENT ARGIMON GUILLEM.

  • Modificaciones Estatutarias

    ART.6,PARRAFO 5:TRANSMISION DE ACCIONES.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2024-145-28 30/07/2024 Madrid Descargar
BORME-A-2019-51-28 14/03/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-67-28 06/04/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-98-08 26/05/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-171-08 07/09/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-86-08 06/05/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-53-08 17/03/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-168-08 04/09/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-226-08 26/11/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-197-08 15/10/2013 Barcelona Descargar