TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALICANTE SA

Extinta

Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 18/02/2016

PARDO IZQUIERDO JOSE LUIS

Administrador solidario
Cese: 18/02/2016

PEREZ MATEO REGADERA JOSE LUIS

Administrador solidario
Cese: 18/02/2016

SOLER SEMPERE MARIA ASUNCION

Apoderado
Cese: 18/02/2016

GOMEZ MARTINEZ MARIA JOSE

Apoderado
Cese: 18/02/2016

NOZAL AYUSO JUAN CARLOS

Apoderado
Cese: 18/02/2016

FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO RAFAEL ANGEL

Apoderado
Cese: 18/02/2016

GIL CELMA FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 19/11/2015

GIL CELMA FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 14/04/2014

FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO RAFAEL ANGEL

Apoderado
Nombramiento: 26/06/2013

NOZAL AYUSO JUAN CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 17/04/2013

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 09/08/2012

PARDO IZQUIERDO JOSE LUIS

Administrador solidario
Nombramiento: 09/08/2012

PEREZ MATEO REGADERA JOSE LUIS

Administrador solidario

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALICANTE SA

18/02/2016 Details of the advert (72348) Registry data: T 2130 , F 71, S 8, H A 17712, I/A 21 ( 9.02.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: PARDO IZQUIERDO JOSE LUIS;PEREZ MATEO REGADERA JOSE LUIS.

  • Revocaciones

    Apoderado: SOLER SEMPERE MARIA ASUNCION;GOMEZ MARTINEZ MARIA JOSE;NOZAL AYUSO JUAN CARLOS;FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO RAFAEL ANGEL;GIL CELMA FRANCISCO JAVIER.

  • Extinción

19/11/2015 Details of the advert (467213) Registry data: T 2130 , F 71, S 8, H A 17712, I/A 20 (12.11.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: GIL CELMA FRANCISCO JAVIER.

14/04/2014 Details of the advert (164027) Registry data: T 2130 , F 58, S 8, H A 17712, I/A 19 ( 7.04.14).

  • Nombramientos

    Apoderado: FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO RAFAEL ANGEL.

26/06/2013 Details of the advert (290316) Registry data: T 2130 , F 58, S 8, H A 17712, I/A 18 (19.06.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: NOZAL AYUSO JUAN CARLOS.

17/04/2013 Details of the advert (179247) Registry data: T 2130 , F 57, S 8, H A 17712, I/A 17 ( 8.04.13).

  • Nombramientos

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

09/08/2012 Details of the advert (335033) Registry data: T 2130 , F 57, S 8, H A 17712, I/A 16 (30.07.12).

  • Reelecciones

    Adm. Solid.: PARDO IZQUIERDO JOSE LUIS;PEREZ MATEO REGADERA JOSE LUIS.

26/08/2011 Details of the advert (359689)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

26/07/2010 Details of the advert (255167)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2010) Año: 2009

11/08/2009 Details of the advert (198136)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2009) Año: 2008

23/01/2009 Details of the advert (36582) Registry data: T 2130 , F 57, S 8, H A 17712, I/A 15 (14.01.09).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo 2º. Objeto social.

Mercantile Registry documents related: 10

#CVE
Date
State
BORME-A-2016-33-03 18/02/2016 Alicante/Alacant Descargar
BORME-A-2015-221-03 19/11/2015 Alicante/Alacant Descargar
BORME-A-2014-72-03 14/04/2014 Alicante/Alacant Descargar
BORME-A-2013-119-03 26/06/2013 Alicante/Alacant Descargar
BORME-A-2013-72-03 17/04/2013 Alicante/Alacant Descargar
BORME-A-2012-152-03 09/08/2012 Alicante/Alacant Descargar
BORME-B-2011-163-03 26/08/2011 Alicante/Alacant Descargar
BORME-B-2010-141-03 26/07/2010 Alicante/Alacant Descargar
BORME-B-2009-151-03 11/08/2009 Alicante/Alacant Descargar
BORME-A-2009-15-03 23/01/2009 Alicante/Alacant Descargar