TELEFONICA INNOVACION ALPHA SL

Extinta

RONDA DE LA COMUNICACION - DISTRITO TELEFONICA (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 11/02/2021

DEL VAL LATORRE DAVID PABLO

Apoderado
Nombramiento: 02/07/2020

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 01/08/2019

ARMENGOL DAVID ROLAND ANTONI

Apoderado
Nombramiento: 01/08/2019

WILIAMS JAMES PETER

Apoderado
Nombramiento: 16/07/2019

CLARAMONTE GIL PEDRO JOSE

Apoderado mancomunado
Cese: 23/04/2019

RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO

Apoderado
Nombramiento: 14/03/2019

CALVO CASTRO CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 05/12/2017

DE ALBURQUERQUE THOMAS PETER

Apoderado solidario
Nombramiento: 17/04/2017

WILIAMS JAMES PETER

Apoderado
Nombramiento: 19/08/2016

ARMENGOL DAVID ROLAND ANTONI

Apoderado
Nombramiento: 23/03/2016

ALEIX ARGUELLES ALFREDO

Apoderado
Nombramiento: 23/03/2016

PEREZ CANTON JESUS

Apoderado
Nombramiento: 23/03/2016

DUCHA SUTIL EVANGELINA

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by TELEFONICA INNOVACION ALPHA SL

04/10/2021 Details of the advert (439618) Registry data: T 34221 , F 219, S 8, H M 615616, I/A 21 (27.09.21).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

06/07/2021 Details of the advert (325328) Registry data: T 34221 , F 219, S 8, H M 615616, I/A 20 (29.06.21).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 297.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.487.000,00 Euros.

11/02/2021 Details of the advert (66789) Registry data: T 34221 , F 218, S 8, H M 615616, I/A 19 ( 4.02.21).

  • Nombramientos

    Apoderado: DEL VAL LATORRE DAVID PABLO.

02/07/2020 Details of the advert (202601) Registry data: T 34221 , F 217, S 8, H M 615616, I/A 18 (25.06.20).

  • Nombramientos

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

01/08/2019 Details of the advert (336221) Registry data: T 34221 , F 217, S 8, H M 615616, I/A 17 (25.07.19).

  • Revocaciones

    Apoderado: ARMENGOL DAVID ROLAND ANTONI.

  • Nombramientos

    Apoderado: WILIAMS JAMES PETER.

16/07/2019 Details of the advert (305743) Registry data: T 34221 , F 217, S 8, H M 615616, I/A 16 ( 9.07.19).

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: CLARAMONTE GIL PEDRO JOSE.

23/04/2019 Details of the advert (178042) Registry data: T 34221 , F 114, S 8, H M 615616, I/A 15 (12.04.19).

  • Revocaciones

    Apoderado: RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO.

14/03/2019 Details of the advert (117834) Registry data: T 34221 , F 114, S 8, H M 615616, I/A 14 ( 7.03.19).

  • Nombramientos

    Apoderado: CALVO CASTRO CARLOS.

29/01/2019 Details of the advert (39923) Registry data: T 34221 , F 113, S 8, H M 615616, I/A 13 (22.01.19).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 186.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.189.750,00 Euros.

05/02/2018 Details of the advert (56918) Registry data: T 34221 , F 113, S 8, H M 615616, I/A 12 (26.01.18).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 650.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.003.000,00 Euros.

Mercantile Registry documents related: 21

#CVE
Date
State
BORME-A-2021-191-28 04/10/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2021-127-28 06/07/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2021-28-28 11/02/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-126-28 02/07/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-146-28 01/08/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-134-28 16/07/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-77-28 23/04/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-51-28 14/03/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-19-28 29/01/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-25-28 05/02/2018 Madrid Descargar